PACIFIC SHELF 1830 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PACIFIC SHELF 1830 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03386793 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Two Snowhill B4 6GA Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BANNER LIMITED | 09. Sept. 1997 | 09. Sept. 1997 |
| JADEDASH LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2018 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2017 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2016 | 7 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD zum Two Snowhill Birmingham B4 6GA am 03. Jan. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2015 | 7 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Stafford Fawcus als Sekretär am 10. Juli 2015 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Thomas Whitby als Geschäftsführer am 10. Juli 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Stafford Fawcus als Geschäftsführer am 10. Juli 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Verschiedenes Sec 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 5 Kennet Way Trowbridge Wiltshire BA14 8BL England zum 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD am 16. Sept. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Blue Max Group Limited Kennet Way Canal Road Industrial Estate Trowbridge Wiltshire BA14 8BL* am 19. Mai 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PACIFIC SHELF 1830 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVAN, Paul Kenmuir Douglas | Geschäftsführer | B4 6GA Birmingham Two Snowhill | England | British | 104904690002 | |||||
| PLENDERLEITH, Nigel Brindley | Geschäftsführer | B4 6GA Birmingham Two Snowhill | United Kingdom | British | 150617020001 | |||||
| FAWCUS, David Stafford | Sekretär | Colmore Row B3 3SD Birmingham 125 | 151926100001 | |||||||
| MCDONALD, Peter | Sekretär | 452 Stockport Road Denton M34 6EQ Manchester | British | 6444050001 | ||||||
| POWELL, Ian Donald | Sekretär | Fernbank Woodend Lane SK14 1DU Hyde Cheshire | British | 37804490002 | ||||||
| ROBSON, Alan James | Sekretär | 14 Mill Place DN35 8ND Cleethorpes North East Lincolnshire | British | 74547040004 | ||||||
| BURNESS SOLICITORS | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CARRICK, Neil Richard | Geschäftsführer | Church Hill Lodge 6a Church Hill HU15 2EU South Cave East Yorkshire | England | British | 166312330001 | |||||
| EDGAR, John Norman | Geschäftsführer | 26 Bollin Close WA13 9PZ Lymm Cheshire | British | 18840600001 | ||||||
| FAWCUS, David Stafford | Geschäftsführer | Colmore Row B3 3SD Birmingham 125 | United Kingdom | Uk | 3193850001 | |||||
| HOCKING, Geoffrey | Geschäftsführer | 43 Western Way NE40 3LR Ryton Tyne & Wear | United Kingdom | British | 54788540001 | |||||
| JONSSON, Per Anders | Geschäftsführer | 263 Petersham Road TW10 7DA Richmond Surrey | England | Swedish | 189569310001 | |||||
| MCDONALD, Peter | Geschäftsführer | 452 Stockport Road Denton M34 6EQ Manchester | British | 6444050001 | ||||||
| MEDDINGS, David William | Geschäftsführer | 13 Montagu Square W1H 1RB London | British | 4416070001 | ||||||
| MORGAN, Philip John | Geschäftsführer | Vale Road Pownall Park SK9 5QA Wilmslow 6 Cheshire | United Kingdom | British | 136271260001 | |||||
| PARROTT, Ian Thomas | Geschäftsführer | Hillhaven 28 Langham Road Bowdon WA14 3NU Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 59164170003 | |||||
| PARTON, Gordon Ramsay | Geschäftsführer | 21 Ramsden Close SK13 9BB Glossop Derbyshire | England | British | 168135010002 | |||||
| PLENDERLEITH, Nigel Brindley | Geschäftsführer | Saddlers Cottage Crabtree Lane WA16 6PE High Legh Cheshire | United Kingdom | British | 150617020001 | |||||
| POWELL, Ian Donald | Geschäftsführer | Fernbank Woodend Lane SK14 1DU Hyde Cheshire | England | British | 37804490002 | |||||
| SCATES, Kenneth Colin | Geschäftsführer | Foxley Hall 149 Higher Lane WA13 0BU Lymm Cheshire | England | British | 18916020001 | |||||
| SCATES, Paul Anthony | Geschäftsführer | 4 Grove Rise WA13 0JQ Lymm Cheshire | England | British | 8803810001 | |||||
| STEVENSON, James Neil | Geschäftsführer | Rathlin Hallpath DG13 0EG Langholm Dumfriesshire | Scotland | British | 759350001 | |||||
| THOMAS, Adrian Peter Harrison | Geschäftsführer | 26 Hartley Road WA14 4AY Altrincham Cheshire | England | British | 26500450003 | |||||
| WHITBY, Christopher Thomas | Geschäftsführer | Colmore Row B3 3SD Birmingham 125 | United Kingdom | British | 83730440001 | |||||
| WILDER, Howard Geoffrey | Geschäftsführer | 93 Little Bushey Lane Bushey WD23 4SD Watford Hertfordshire | England | British | 58223560002 | |||||
| WOOD, Frederick William | Geschäftsführer | Pleasant House Pleasant Place LN11 0NA Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 3783250004 | |||||
| ZIHA, Carolyn Marie | Geschäftsführer | Ivy Close Clayton Le Woods PR25 5SG Preston 10 Lancashire England | England | British | 129202210001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| WJB (DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 12 Hope Street EH2 4DD Edinburgh Lothian | 39110950001 |
Hat PACIFIC SHELF 1830 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge on non-vesting debts and floating charge | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 26. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all debts, purportedly assigned to the chargee pursuant to the debt purchase agreement, all associated rights relating to any non-vesting domestic debts, all export debts and all associated rights, , the excluded proceeds, first floating charge all present and future assets and undertaking see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. März 2009 Geliefert am 21. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. März 2009 Geliefert am 21. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on north side castlereagh road seaham easington durham t/no:DU125343 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 2008 Geliefert am 10. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H castlereagh tempest road seaham county durham t/no DU125343 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 2008 Geliefert am 22. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at castlereagh seaham county durham t/no DU125343. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a land and buildings at dene house road easington county durham t/no du 39447. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1997 Geliefert am 09. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as jadedash limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PACIFIC SHELF 1830 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0