SEAHAM HALL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSEAHAM HALL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03391036
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SEAHAM HALL LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
    • Unlizenzierte Restaurants und Cafés (56102) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich SEAHAM HALL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SEAHAM HALL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SEAHAM HALL LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SEAHAM HALL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72
    A34YI61F

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Aug. 2013

    14 Seiten4.68
    A2M2M617

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Kings Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3LG United Kingdom* am 10. Sept. 2012

    2 SeitenAD01
    A1GKHU2H

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    4 Seiten4.20
    A1GKHU1T

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A1GKHU29

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 18. Juni 2012

    • Kapital: GBP 5,000,000
    SH01
    X1BB4W4X

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    24 SeitenAA
    A190HVWI

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Von Essen House Roman Way Bath Business Park, Peasedown St. John Bath BA2 8SG United Kingdom* am 27. Apr. 2012

    1 SeitenAD01
    X17QEMN7

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD
    A0OVESU1

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02
    XI8CIWR4

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    XEAD9WEH

    Ernennung von Blakelaw Secretaries Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04
    XDQ0KWDT

    Beendigung der Bestellung von Gd Secretarial Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XDPY9WDF

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sixth Floor 90 Fetter Lane London EC4A 1PT* am 08. Juli 2011

    1 SeitenAD01
    X4ZH4VN3

    Ernennung von David Duggins als Direktor

    3 SeitenAP01
    L76HCUG1

    Beendigung der Bestellung von Andrew Davis als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01
    L76G8UGW

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA
    LKBK1MSF

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    XVQKOL2D

    Änderung der Details des Sekretärs für Gd Secretarial Services Limited am 18. Juni 2010

    2 SeitenCH04
    XVQKNL2C

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    14 SeitenAA
    LZ7ELEFJ

    legacy

    3 Seiten363a
    XTCC8BIF

    legacy

    3 Seiten363a
    XB8YX12E

    Wer sind die Geschäftsführer von SEAHAM HALL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1914417
    38915800008
    DUGGINS, David
    Roman Way, Bath Business Park
    Peasedown St. John
    BA2 8SG Bath
    Von Essen House
    Geschäftsführer
    Roman Way, Bath Business Park
    Peasedown St. John
    BA2 8SG Bath
    Von Essen House
    United KingdomBritishDirector160494140001
    ARNOTT, Michael Leslie
    58 Fawcett Street
    SR1 1RY Sunderland
    Tyne And Wear
    Sekretär
    58 Fawcett Street
    SR1 1RY Sunderland
    Tyne And Wear
    British57190200001
    BRAID, Stephen Philip
    7 Glenorrin Close
    Lambton
    NE38 0DZ Washington
    Tyne & Wear
    Sekretär
    7 Glenorrin Close
    Lambton
    NE38 0DZ Washington
    Tyne & Wear
    BritishAccountant13198890001
    FINNIGAN, David Thomas
    60 Pilgrims Way
    DH1 1HQ Durham
    County Durham
    Sekretär
    60 Pilgrims Way
    DH1 1HQ Durham
    County Durham
    BritishAccountant106186210001
    MAXFIELD, Judith Anne
    Marsden Hall Lizard Lane
    NE34 7AD Marsden
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Marsden Hall Lizard Lane
    NE34 7AD Marsden
    Tyne & Wear
    British53477580001
    RICHARDSON, Andrew
    58 Beadnell Drive
    East Shore Village
    SR7 7WG Seaham
    County Durham
    Sekretär
    58 Beadnell Drive
    East Shore Village
    SR7 7WG Seaham
    County Durham
    BritishAccountant103533890002
    SUGGETT, Ian Raymond
    35 Birkdale Gardens
    Belmont
    DH1 2UJ Durham
    County Durham
    Sekretär
    35 Birkdale Gardens
    Belmont
    DH1 2UJ Durham
    County Durham
    BritishAccountant123399900001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sixth Floor
    90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Goodman Derrick
    England
    Sekretär
    Sixth Floor
    90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Goodman Derrick
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02471626
    66216820001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRAID, Stephen Philip
    7 Glenorrin Close
    Lambton
    NE38 0DZ Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    7 Glenorrin Close
    Lambton
    NE38 0DZ Washington
    Tyne & Wear
    EnglandBritishAccountant13198890001
    DAVIS, Andrew
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director77124350001
    FINNIGAN, David Thomas
    60 Pilgrims Way
    DH1 1HQ Durham
    County Durham
    Geschäftsführer
    60 Pilgrims Way
    DH1 1HQ Durham
    County Durham
    BritishAccountant106186210001
    MAXFIELD, Jocelyn
    Flass Vale Hall
    Crossgate Moor
    DH1 4HR Durham
    County Durham
    Geschäftsführer
    Flass Vale Hall
    Crossgate Moor
    DH1 4HR Durham
    County Durham
    United KingdomBritishHotelier78803650003
    MAXFIELD, Thomas Patrick
    Flass Vale Hall
    DH1 4HR Crossgate Moor
    Durham
    Geschäftsführer
    Flass Vale Hall
    DH1 4HR Crossgate Moor
    Durham
    EnglandBritishCompany Director24954700003
    RHATIGAN, Simon
    6 Akenside House
    Quayside
    NE1 3UF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    6 Akenside House
    Quayside
    NE1 3UF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishHotelier78790390003
    RICHARDSON, Andrew
    58 Beadnell Drive
    East Shore Village
    SR7 7WG Seaham
    County Durham
    Geschäftsführer
    58 Beadnell Drive
    East Shore Village
    SR7 7WG Seaham
    County Durham
    EnglandBritishAccountant103533890002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat SEAHAM HALL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 19. März 2008
    Geliefert am 02. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and by each other chargor and non-chargor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings lying on the south east of byron's walk, seaham t/no. DU87579; l/h land on the south side of lord byron's walk, seaham t/no. DU221058; f/h the cottage, seaham hall, seaham t/no. DU85454 (for details of further properties charged please refer to form 395). by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings lying to the south east of byron's walk, seaham t/no. DU87579; l/h land on the south side of lord byron's walk, seaham t/no. DU221058; f/h the cottage, seaham hall, seaham t/no. DU85454 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Feb. 2003
    Geliefert am 20. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land being seaham hall,seaham t/no DU111483;the f/h land being land to the south of seaham hall,seaham t/no DU138669;the f/h land being an electricity sub station lying to the west of seaham hall,seaham t/no DU185440 for further details of properties charged please refer to form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Feb. 2003
    Geliefert am 20. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SEAHAM HALL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Aug. 2012Beginn der Liquidation
    04. Juli 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praktiker
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Vivienne Elizabeth Oliver
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praktiker
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0