WRAITH ACCOMMODATION LIMITED

WRAITH ACCOMMODATION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWRAITH ACCOMMODATION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03392515
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HEIGHT MASTER HIRE LTD.26. Juni 199726. Juni 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Manor Drive Peterborough PE4 7AP* am 01. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Juli 2013

    Kapitalaufstellung am 22. Juli 2013

    • Kapital: GBP 3,362,623
    SH01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 20 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    5 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Mark Eburne als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von WRAITH ACCOMMODATION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DE EPALZA, Joana
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    French171133460001
    DE EPALZA, Joana
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomFrench171133460001
    EBURNE, Mark Andrew
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish134516800001
    ANDERSON, Thomas
    37 Vermont Grove
    PE3 6BN Peterborough
    Cambridgeshire
    Sekretär
    37 Vermont Grove
    PE3 6BN Peterborough
    Cambridgeshire
    British1333060001
    BATTERSBY, Jonathan Simon
    279 Carter Knowle Road
    S11 9FX Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    279 Carter Knowle Road
    S11 9FX Sheffield
    South Yorkshire
    British50615240001
    CRAVEN, Heather Ann
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    British110004900001
    HOGG, John Anthony
    Home
    Main Street, Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Home
    Main Street, Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    British65989030001
    NEWMAN, Lesley Ann
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    Sekretär
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    British54725270001
    THOMPSON, Ian Patrick Russell
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    Sekretär
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    British148048600001
    WALKER, Maria
    4 Pond Close Long Furrow
    Welton
    LN2 3UE Lincoln
    Sekretär
    4 Pond Close Long Furrow
    Welton
    LN2 3UE Lincoln
    British73557530001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON, Thomas
    37 Vermont Grove
    PE3 6BN Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    37 Vermont Grove
    PE3 6BN Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish1333060001
    BATTERSBY, Jonathan Simon
    279 Carter Knowle Road
    S11 9FX Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    279 Carter Knowle Road
    S11 9FX Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish50615240001
    EBURNE, Mark Andrew
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    Geschäftsführer
    Manor Drive
    Peterborough
    PE4 7AP
    EnglandBritish134516800001
    O CONNOR FENTON, Timothy
    The Old Rectory
    South Kilvington
    YO7 2NL Thirsk
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    South Kilvington
    YO7 2NL Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish84222620001
    O'KELLY, Paul Brian
    Lincombe Lane
    Boars Hill
    OX1 5DX Oxford
    The Croft
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Lincombe Lane
    Boars Hill
    OX1 5DX Oxford
    The Croft
    Oxfordshire
    United KingdomBritish184075280001
    ROBERTSON, Stephen James
    Clarendon House
    2 Clarendon Close
    W2 2NS London
    Geschäftsführer
    Clarendon House
    2 Clarendon Close
    W2 2NS London
    United KingdomBritish78505200003
    SMITH, Duncan
    161 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DS Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    161 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DS Wakefield
    West Yorkshire
    British72708680001
    THOMPSON, Ian Patrick Russell
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    Geschäftsführer
    Manor Drive
    PE4 7AP Peterborough
    Elliott Group Ltd
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish148039890001
    WALKER, Maria
    4 Pond Close Long Furrow
    Welton
    LN2 3UE Lincoln
    Geschäftsführer
    4 Pond Close Long Furrow
    Welton
    LN2 3UE Lincoln
    British73557530001
    WATT, Peter
    33 Wyndham Street
    W1H 1ED London
    Geschäftsführer
    33 Wyndham Street
    W1H 1ED London
    Australian74978540001
    WRAITH, David John
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish23040200001
    WRAITH, David Jonathan
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Bellwood Grange Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish39191320001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat WRAITH ACCOMMODATION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Master assignment
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment entered into pursuant to the master assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Erstellt am 07. Sept. 2006
    Geliefert am 09. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights, title and interest of the company in sub leases made or to be made by the company in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements made or to be made between the chargee and the company together with the benefit of all collateral agreements, guarantees, indemnities, negotiable instruments, securities and insurance policies taken by the company in connection with the agreements.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Sept. 2006
    Geliefert am 09. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,250,000.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    The items as listed on the schedule attached to the form 395 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Master agreement and charge
    Erstellt am 08. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any agreement made between the customer and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire and all agreements and collateral thereon; the benefit of all securities and guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Finance Company as Defined on Form 395
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Asset sub-hire agreement
    Erstellt am 16. Feb. 2004
    Geliefert am 23. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights, title and interest in sub-hire agreements and related contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 07. Juli 2003
    Geliefert am 09. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First all sub-hiring agreements which may be entered into at any time by the company with its customers relating to goods now or in the future owned by the chargee by let by the chargee to the company under hire-purchase agreements entered into at any time between the chargee and the company or sold by the chargee to the company under conditional sale agreements entered into at any time between the chargee and the company. Secondly all moneys payable under the said sub-hiring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Udt Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture over contract hire and leasing agreements
    Erstellt am 07. Apr. 2003
    Geliefert am 08. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Charge over the benefit of related sub hire contracts.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 24. Jan. 2003
    Geliefert am 27. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    SST126 3 tread step units : SST127, SST128 & SST129 13 tread staircase system X3 (for further chattels charged refer to form 395).
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of keyman life policy
    Erstellt am 27. Sept. 2002
    Geliefert am 15. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder, company: cassidy davis life syndicate, policy number: A6353/02, date: 02/09/1999, sum: £400000.00, life assured: david john wraith.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of keyman life policy
    Erstellt am 27. Sept. 2002
    Geliefert am 15. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder, company: cassidy davis life syndicate, policy number: N1108/02/05, date: 26/06/2000, sum: £500000.00, life assured: david jonathan wraith senior.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of keyman life policy
    Erstellt am 27. Sept. 2002
    Geliefert am 15. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder, company: cassidy david life syndicate, policy number: N1110/02/05, date: 26/06/2000, sum: £500000.00, life assured: david jonathan wraith junior.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 20. Aug. 2002
    Geliefert am 31. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights, title and interest of the company in sub-hire agreements now made or hereafter..in respect of the goods comprised in the hire purchase agreement 100077. see charge particulars for details.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Asset Finance LTD
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment
    Erstellt am 18. Juli 2002
    Geliefert am 02. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due under any sub-hire agreements (as defined in the assignment) and the benefit of all guarantees,indemnities and securities thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 04. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 18. Okt. 2001
    Geliefert am 19. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in sub-hire agreements in respect of the goods comprised in the hire purchase agreement 10057 dated 18 october 2001.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master agreement
    Erstellt am 28. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Legal assignment all the company's rights title and interest in and to the sub-hire agreements described in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relatig thereto and all (if any) the right of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof, legal assignment over all of the company's rights title and interest in and to the specific contracts in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement equitable assignment all the company's right title and interest in and to sub-hire agreements specific contracts and ancillary contracts at any time entered into in respect of goods from time to time supplied under finance agreements by the mortgagee or in substitution for assets stated above and in any other contracts insofar as they relate to goods described in any of the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Leasing Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Erstellt am 16. Juni 2000
    Geliefert am 20. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the rights,title and interest of the company in sub leases now made or hereafter to be made by the company in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements now or hereafter made between barclays mercantile business finance limited and the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Highland Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture deed
    Erstellt am 22. Apr. 1998
    Geliefert am 24. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WRAITH ACCOMMODATION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Nov. 2015Aufgelöst am
    13. Juni 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Eldridge
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0