GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED

GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03399276
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    • Filmverleih (59131) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRITT ALLCROFT (DISTRIBUTION) LIMITED01. Juli 199701. Juli 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2015

    20 Seiten4.68
    A50KYJ1S

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    23 Seiten4.71
    A4YI49ZE

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2014

    14 Seiten4.68
    A40NUXO8

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02
    A31M82EB

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2013

    15 Seiten4.68
    A31OTWPC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Maple House, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 7NF am 28. Dez. 2012

    2 SeitenAD01
    A1O79M2Z

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70
    A1O79M2I

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:special resolution :- "in specie"
    2 SeitenLIQ MISC RES
    Q1O58Z3C

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A1O79M2R

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Approve the implementation of those aspects of the simplification excise relating to the company and other company business 11/12/2012
    RES13

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Juli 2012 bis 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA01
    X19DP0VN

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2011

    6 SeitenAA
    A17Y2MFK

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christian Thieme am 24. März 2012

    2 SeitenCH01
    X16Q9TW3

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christian Thieme am 24. März 2012

    2 SeitenCH01
    X15Q4Z4O

    Ernennung von Mr Christian Thieme als Direktor

    2 SeitenAP01
    X14KOK22

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Walker als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X14KOLVL

    Ernennung von Sukhjiwan Kaur Tung als Sekretär

    3 SeitenAP03
    A12VIZJN

    Ernennung von Mr Geoffrey Hulbert Walker als Direktor

    3 SeitenAP01
    A12VIZJF

    Ernennung von David Allmark als Direktor

    3 SeitenAP01
    A12VIZJ7

    Ernennung von Edward Laurence Catchpole als Direktor

    3 SeitenAP01
    A12VIZIZ

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Dunn als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01
    A12VIZIR

    Beendigung der Bestellung von Sangeeta Desai als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01
    A12VIZIJ

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Appointing directors 01/02/2012
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SALVO, Joseph Pasqualino
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Sekretär
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Other135617080001
    TUNG, Sukhjiwan Kaur
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Sekretär
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    British166893590001
    ALLMARK, David
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Geschäftsführer
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United StatesBritishEvp Global Brands Team166738850001
    CATCHPOLE, Edward Laurence
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Geschäftsführer
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritishUnited Kingdom166738690001
    THIEME, Christian
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Geschäftsführer
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    EnglandGermanFinancial Director, Mattel, Inc.167467740002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Sekretär
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Sekretär
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Sekretär
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    BritishChartered Accountant45519470002
    PEARCE, Simon Marshall
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    Sekretär
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    British38325900002
    ROWLAND, Janet Lesley
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Sekretär
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    British83715050001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLCROFT, Britt
    133 Wadsworth Avenue
    90405 Santa Monica
    California 90405 Usa
    Geschäftsführer
    133 Wadsworth Avenue
    90405 Santa Monica
    California 90405 Usa
    United StatesBritishDeputy Chairman51938020002
    BIRRELL, Nigel Norman
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    Geschäftsführer
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    BritishDirector Corporate Development72014940002
    CAMINADA, Charles Jerome
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    Geschäftsführer
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    EnglandBritishCompany Director114598050001
    DESAI, Sangeeta
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Geschäftsführer
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United KingdomBritishChief Operating Officer80563180001
    DUNN, Jeffrey Doubleday
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Geschäftsführer
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmericanBusiness Executive129211540001
    FALZON, Charles John
    R R Flat 2
    Acton
    Ontario L7j 2lb
    Canada
    Geschäftsführer
    R R Flat 2
    Acton
    Ontario L7j 2lb
    Canada
    CanadianPresident74244420001
    HARRIS, William Stuart
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishChief Executive1444030002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    BritishFinance Director45519470002
    LAWES, Robert Ian
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    Geschäftsführer
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    BritishCompany Director24399410004
    PEARCE, David
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    Geschäftsführer
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    EnglandBritishDeputy Chief Financial Officer89691560001
    RICKETTS, Timothy Walker
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    EnglandBritishDirector119035710001
    SANGWAY, Susan Annette
    Nuthatch Cottage
    The Common Dean Road West Tytherley
    SP5 1NS Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Nuthatch Cottage
    The Common Dean Road West Tytherley
    SP5 1NS Salisbury
    Wiltshire
    BritishMarketing Director45322720001
    STEINBERG, Bruce David
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    Geschäftsführer
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    United KingdomAmericanCompany Director107396950001
    SULLIVAN, Sean Stephen
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Geschäftsführer
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmericanChief Financial Officer135856320001
    WALKER, Geoffrey Hulbert
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    United KingdomAmericanSvp & Gm Uk/Eastern Europe158295080001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director73750450005
    WRIGHT, Angus Mackenzie Nicholson
    11 Blenheim Avenue
    SO17 1DW Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    11 Blenheim Avenue
    SO17 1DW Southampton
    Hampshire
    BritishDeputy Chairman69269050001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 14. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) on the terms and conditions set out in the facility agreement (the "security trustee") or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of further advances made under the finance documents and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GULLANE (DISTRIBUTION) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    15. Apr. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0