FATE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFATE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03404944
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FATE LIMITED?

    • Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich FATE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FATE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für FATE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2020

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2021

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2019

    12 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. März 2018

    16 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Solar House 282 Chase Road London N14 6NZ zum 1 Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA am 19. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 31. März 2017

    LRESEX

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 034049440008, erstellt am 18. Mai 2016

    37 SeitenMR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Filip Filipovic als Sekretär am 15. Juli 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2013

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Juli 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Juli 2013

    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Dragisa Ilic am 13. Juli 2012

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von FATE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ILIC, Dragisa
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    Geschäftsführer
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    United KingdomBritish95447780001
    FILIPOVIC, Filip
    282 Chase Road
    N14 6NZ London
    Solar House
    United Kingdom
    Sekretär
    282 Chase Road
    N14 6NZ London
    Solar House
    United Kingdom
    British70122340002
    STEFANOV, Stefan
    147 Lupus Street
    SW1V 3ND London
    Sekretär
    147 Lupus Street
    SW1V 3ND London
    British71201060001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    PERUGINI, Marco
    26 Eagle Heights
    8 Bramlands Close
    SW11 2LJ London
    Geschäftsführer
    26 Eagle Heights
    8 Bramlands Close
    SW11 2LJ London
    Italian70251410002
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FATE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Dragisa Ilic
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    30. Juni 2016
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat FATE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Mai 2016
    Geliefert am 31. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Legal charge dated 18TH may 2016 relating to 228 york road london SW11 3SJ.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Jamal Abraham
    Transaktionen
    • 31. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal and general charge
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 25. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Little bay restaurant 228 york road battersea london, all uncalled capital all intellectual property rights and all other f/h and l/h property now or in the future any legal or beneficial interest in all securitites stock in trade and plant book debts.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £154,800.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • B M Samuels Finance Group PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 26. Aug. 2004
    Geliefert am 01. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    32 selsdon road south croydon by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge of licenced premises
    Erstellt am 15. März 2004
    Geliefert am 18. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    228 york road battersea london, the benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 2004
    Geliefert am 12. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Aug. 2000
    Geliefert am 09. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 101 falcon road battersea london SW11 - 272329. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 06. Aug. 1997
    Geliefert am 11. Aug. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The obligations on the part of the tenant contained in a lease dated 6 august 1997 and for payment of all monies due or to become due from the tenant to the landlord pursuant to the obligations of the lease and for the due performance of all obligations and liabilities of the tenant thereunder
    Kurze Angaben
    The security deposit of £5,000 paid under the deed of deposit of rent and all other sums from time to time constituting the same and any additional sums paid into the deposit account pursuant to the said deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Mirrordeal Limited
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Hat FATE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. März 2017Beginn der Liquidation
    30. Aug. 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    Praktiker
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0