TREASURY (GP) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTREASURY (GP) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03406548
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TREASURY (GP) LIMITED?

    • (7011) /
    • (9999) /

    Wo befindet sich TREASURY (GP) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    188 Kirtling Street
    SW8 5BN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TREASURY (GP) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GE CAPITAL CORPORATION (TOLWORTH GP) LIMITED27. Nov. 199727. Nov. 1997
    SHELFCO (NO. 1386) LIMITED21. Juli 199721. Juli 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TREASURY (GP) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für TREASURY (GP) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Aug. 2010

    Kapitalaufstellung am 03. Aug. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Joseph Barrett am 21. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2009 bis 28. Feb. 2010

    3 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Juli 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 42 Albemarle Street London W1S 4JH am 06. Okt. 2009

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    11 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    14 Seiten395

    legacy

    14 Seiten395

    legacy

    14 Seiten395

    legacy

    14 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    10 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    11 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TREASURY (GP) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NEWMAN, Karen
    Elm Tree Cottage
    Bramley Road
    RG7 2LJ Silchester
    Berkshire
    Sekretär
    Elm Tree Cottage
    Bramley Road
    RG7 2LJ Silchester
    Berkshire
    British86955250001
    BANHAM, Sarah Linda Jane
    Juer Street
    SW11 4RE London
    21
    Geschäftsführer
    Juer Street
    SW11 4RE London
    21
    EnglandBritish111901230001
    BARRETT, Richard Joseph
    97 Upper Leeson Street
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    97 Upper Leeson Street
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish55740270001
    RONAN, John
    Dargle Cottage, Dargle
    Enniskerry
    County Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Dargle Cottage, Dargle
    Enniskerry
    County Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish117482280001
    BEATTIE-JONES, Vanessa Avril
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    British59539540002
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    LEE, Tony
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    British49293090003
    YEEND, John Charles
    Ash House 22 Downs Side
    SM2 7EQ Sutton
    Surrey
    Sekretär
    Ash House 22 Downs Side
    SM2 7EQ Sutton
    Surrey
    British127728330001
    BOODLE HATFIELD SECRETARIAL LIMITED
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    Sekretär
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    47722940004
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    BEATTIE-JONES, Vanessa Avril
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    31 Wyndham Road
    KT2 5JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish59539540002
    COLLINS, Mark
    28 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AB London
    Geschäftsführer
    28 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AB London
    British56836220001
    DE BIE, Janet
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    Geschäftsführer
    70 Franche Court Road
    SW17 0JU London
    British105858010001
    HOWARD, Mervyn
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    Geschäftsführer
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    United KingdomBritish52891020001
    LEECH, Guy William
    Moor Hatches
    West Amesbury
    SP4 7BH Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Moor Hatches
    West Amesbury
    SP4 7BH Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish35522320002
    LEMASS, Deirdre Elizabeth
    25 Camden Row
    IRISH Dublin 8
    Ireland
    Geschäftsführer
    25 Camden Row
    IRISH Dublin 8
    Ireland
    Irish73819350001
    OBI-EZEKPAZU, Anthony Ifeanychukwu
    Flat 3 122 Aldermans Hill
    N13 4PT London
    Geschäftsführer
    Flat 3 122 Aldermans Hill
    N13 4PT London
    British62852800001
    POWERS, Richard Hart
    6 Bramerton Street
    SW3 5JX London
    Geschäftsführer
    6 Bramerton Street
    SW3 5JX London
    American69037180002
    THURGAR, David Victor Marshall
    7 Morris Close
    BR6 9TE Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    7 Morris Close
    BR6 9TE Orpington
    Kent
    British67012120003
    WILLIAMS, Edward Donat
    16 Sherwood Avenue
    HA4 7XL Ruislip
    Middlesex
    Geschäftsführer
    16 Sherwood Avenue
    HA4 7XL Ruislip
    Middlesex
    United KingdomBritish93624550001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    Hat TREASURY (GP) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security interest agreement
    Erstellt am 22. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority security interest in the collateral.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, London Branch
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 22. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale London Branch
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 20. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority security interest in the collateral.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen - Thuringen Girozentrale, London Branch
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 20. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the debtors to the chargee and/or the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority security interst in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen - Thuringen Girozentrale London Branch
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge (the deed) taken pursuant to a debenture dated 19 december 2000 between the second borrower, the first general partner, the second general partner and mable commercial funding limited as agent of the lenders under (as defined) the facility agreement (the agent)
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 10. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All and any moneys, obligations and liabilities due or to become due by the obligors (as defined) to the finance parties (as defined) under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the freehold land being 17-23 (odd) beargarden road cherwell in the county of oxfordshire title numbers ON80813 and ON129394 together with all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures belonging to it) now and in the future thereon and all plant and machinery now and in the future.
    Berechtigte Personen
    • Mable Commercial Funding Limited as Agent of the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge pursuant to a debenture dated 19TH september 2000 between the second borrower, the first general partner, the second general partner and the chargee under (and as defined in) the facility agreement
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 05. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All and any moneys obligations and liabilities due owing and incurred by the obligors to the finance parties under the terms of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All that f/h land being 17-23 (odd) beargarden road cherwell county of oxfordshire t/no;'-ON80813 and ON129394 together with all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures belonging to it) and all plant and machinery annexed thereto.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, London Branch (As Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture between treasury (gp) limited and bikler limited as general partners of the thl uxbridge limited partnership and mable commercial funding limited as agent of the lenders under (and as defined in) the facility agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2000
    Geliefert am 29. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due by the obligors (as defined) to the finance parties (as defined) under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mable Commercial Funding Limited as Agent of the Lenders Under (And as Defined In) the Facility Agreement
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture between treasury (gp) limited and newent limited as general partners of the thl tolworth limited partnership and mable commercial funding limited as agent of the lenders under (and as defined in) the facility agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2000
    Geliefert am 29. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due by the obligors (as defined) to the finance parties (as defined) under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mable Commercial Funding Limited as Agent of the Lenders Under (And as Defined In) the Facility Agreement
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture between treasury (gp) limited (in its capacity as general partner of the thl tolworth limited partnership and in its own capacity) and landesbank hessen-thuringen girozentrale, london branch
    Erstellt am 19. Dez. 2000
    Geliefert am 29. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) to the finance parties (as defined) in whatever currency under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale (London Branch)
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture between treasury (gp) limited (in its capacity as general partner of the thl uxbridge limited partnership and in its own capacity) and landesbank hessen-thuringen girozentrale, london branch
    Erstellt am 19. Dez. 2000
    Geliefert am 29. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) to the finance parties (as defined) in whatever currency under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, London Branch as Agent of Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    A legal charge made between the company (in its own capacity) and bikler limited as general partners of the thl uxbridge limited partnership and ge capital corporation (tolworth gp) limited and newent limited as general partners of the thl tolworth limited partnership and ge capital corporation (funding) limited
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The company (the "partnership") covenants to pay and discharge to the chargee on the due date or dates all present and/or future indebtedness of the "partnership" and the thl uxbridge limited partnership to the chargee whether actual and/or contingent, present or future, alone or jointly or as principal or surety that may be due pursuant to any security documents (as defined) and all interest on the foregoing
    Kurze Angaben
    Tolworth tower tolworth surrey and 435 ewell road tolworth t/n's SGL237093 and SY260410 and stuart house peterborough t/n's CB44891 and CB178969, floating charge the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A legal charge made between the company (in its own capacity) and bikler limited as general partners of the thl uxbridge limited partnership and ge capital corporation (tolworth gp) limited and newent limited as general partners of the thl tolworth limited partnership and ge capital corporation (funding) limited
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The company (the "partnership") covenants to pay and discharge to the chargee on the due date or dates all present and/or future indebtedness of the "partnership" and the thl tolworth limited partnership to the chargee whether actual and/or contingent, present or future, alone or jointly or as principal or surety that may be due pursuant to any security documents (as defined) and all interest on the foregoing
    Kurze Angaben
    36-50 george street altrincham t/n GM615002; crwon centre stourbridge t/n WM319506; 9-13 newgate street bishops auckland t/n DU213489, for details of further properties charged, please refer to form M395; floating charge the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge made between the company and bikler limited as general partners of the thl uxbridge limited partnership and the company and newent limited as general partners of the thl tolworth limited partnership and ge capital corporation (trading LP) limited
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities and obligations of the partnership and the thl tolworth limited partnership covenanted to be paid or performed by the partnership and the thl tolworth limited partnership pursuant to clause 18 of the partnership agreement to the chargee
    Kurze Angaben
    36-50 george street altrincham t/no GM615002 crown centre stourbridge WM319506 9-13 newgate street bishops aukland DU213489 bakers court uxbridge middx NGL542402 and all the other properties as detailed on the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Trading LP) Limited
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge made between the company and bikler limited as general partners of the thl uxbridge limited partnership and the company and newent limited as general partners of the thl tolworth limited partnership and ge capital corporation (trading LP) limited
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities and obligations of the partnership and the thl uxbridge limited partnership covenanted to be paid or performed by the partnership and the thl uxbridge limited partnership pursuant to clause 18 of the partnership agreement to the chargee
    Kurze Angaben
    Tolworth tower tolworth surrey and 435 ewell road tolworth t/no SGL237093 SY260410 stuart house peterborough t/no CB44891 CB178969. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Corporation (Trading LP) Limited
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0