TOUCH GROUP PLC
Überblick
Unternehmensname | TOUCH GROUP PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 03407323 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOUCH GROUP PLC?
- (7415) /
Wo befindet sich TOUCH GROUP PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o DAVID RUBIN & PARTNERS Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOUCH GROUP PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AMBIENT PLC | 25. Aug. 1999 | 25. Aug. 1999 |
AMBIENT MEDIA CORPORATION PLC | 23. Juli 1997 | 23. Juli 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOUCH GROUP PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOUCH GROUP PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 15 Seiten | 4.72 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2015 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2014 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2013 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 28 Seiten | 4.20 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Saffron House 6-10 Kirby Street London EC1N 8TS* am 26. Juli 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Lorenz als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Brown als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 44 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2011 mit umfangreicher Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. Feb. 2011
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 1 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 43 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 71 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2010 mit umfangreicher Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TOUCH GROUP PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATZ, Peter David | Sekretär | Apartment 8 Alexandra House Richmond Drive IG8 8RF Woodford Green Essex | British | 64682050002 | ||||||
GREEN, Timothy Charles | Geschäftsführer | 204a Edwin Road ME8 0JL Gillingham Kent | British | Director | 126717770001 | |||||
ISAACS, Vincent Joseph | Geschäftsführer | The Penthouse Flat 7 The Heaths 61 West Heath Road NW3 7TH London | United Kingdom | British | Director | 38705920003 | ||||
KATZ, Peter David | Geschäftsführer | Apartment 8 Alexandra House Richmond Drive IG8 8RF Woodford Green Essex | England | British | Director | 64682050002 | ||||
WINSHIP, Stuart | Geschäftsführer | Flat 2 Marie Carlile Coley Avenue GU22 7RG Woking Surrey | England | British | Director | 107388320002 | ||||
ARNOLD, Michael | Geschäftsführer | Dormer Cottage The Chase Kingswood KT20 6HY Tadworth Surrey | United Kingdom | British | Consulting Actuary | 1399970001 | ||||
ASHLEY, Paul Martyn | Geschäftsführer | 10 Wythburn Court Seymour Place W1H 7NS London | England | British | Director | 35065720001 | ||||
BEERLING, Kevin | Geschäftsführer | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | England | British | Director | 64677850002 | ||||
BERKIN, Sukru Emre | Geschäftsführer | Koybasi Cad 257 Yenikoy FOREIGN Istanbul Turkey | Turkish | Business Executive | 108708690001 | |||||
BRIER, Timothy | Geschäftsführer | 202 Dans Highway CT 06840 New Canaan Usa | American | Director | 70808490001 | |||||
BROWN, Neil Graeme | Geschäftsführer | 2 Aldenham Avenue WD7 8HJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 49772410001 | ||||
CARBY, Keith Arthur | Geschäftsführer | New Bridge Square SN1 1HN Swindon The Tri Centre Wiltshire | British | Director | 12732100004 | |||||
DREW, Darren Paul | Geschäftsführer | 14 Beech Road TN13 1YG Sevenoaks Kent | British | Director | 118823420001 | |||||
GOODRICH, Michael John | Geschäftsführer | 37 Eglantine Road SW18 2DE London | England | British | Marketing Consultant | 41860850001 | ||||
HORROCKS, Mark Ian | Geschäftsführer | 18 Three Kings Yard W1K 4JT London | England | British | Director | 5412300001 | ||||
JACOBSON, Ronald Terry | Geschäftsführer | Abbotswood The Pastures N20 8AN London | United Kingdom | British | Stockbroker | 46756400001 | ||||
KILBRIDE, Ian William Sefton | Geschäftsführer | Oakwood 7 Oakhurst Avenue Hout Bay 7806 Cape Town Western Cape South Africa | British | Director | 75544810001 | |||||
LEVENE, Nicholas David Andrew | Geschäftsführer | The Briars Barnet Road EN5 3JZ Arkley Hertfordshire | British | Director | 58316700003 | |||||
LORENZ, Robert Roman | Geschäftsführer | 3561 Tolland Road Shaker Heights Ohio Usa | American | Surgeon | 119520250001 | |||||
OZMEN, Tamer | Geschäftsführer | Flat 6 27-29 Britten Street SW3 3UD London | American | Director | 93689370001 | |||||
REVELL-SMITH, Peter Anning | Geschäftsführer | 78 Palace Gardens Terrace W8 4RS London | British | Investment Banker | 1602410001 | |||||
ROSS, Lionel Jack | Geschäftsführer | 15 Valencia Road HA7 4JL Stanmore Middlesex | British | Director | 1338810002 | |||||
SAKLATVALA, Theresa, Doctor | Geschäftsführer | Lonsdale Road Barnes SW13 9DA London | British | Director | 117894860001 | |||||
STANLEY, Paul Robert | Geschäftsführer | 7 Northolm HA8 9RL Edgware Middlesex | British | Director | 58251370002 | |||||
STIMPSON, Andrew David | Geschäftsführer | 4 Hartswood Road W12 9NQ London | England | British | Director | 99393670001 | ||||
STUTTAFORD, William Royden, Sir | Geschäftsführer | Moulshams Manor Great Wigborough CO5 7RL Colchester Essex | British | Investment Manager | 6071220001 | |||||
USSI, Gino | Geschäftsführer | 18 Avenue Mansions Finchley Road NW3 7AX London | Italian | Director | 50943380002 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
Hat TOUCH GROUP PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Jan. 2011 Geliefert am 15. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 08. Mai 2009 Geliefert am 15. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £126,195.00 plus a sum equivalent to value added tax thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Cash collateral account charge | Erstellt am 23. März 2004 Geliefert am 25. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and touch (nw) limited (the obligors) and each of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in the account held by the company with the lender designated "manager obligation account for touch (nw) limited" with account no. 06023956 and the deposit being the amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Okt. 2001 Geliefert am 10. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the borrower and each other obligor to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto or on any other account whatsoever together with all expenses and any interest charged under the terms of the debenture (all terms as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 09. Feb. 2001 Geliefert am 13. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date | |
Kurze Angaben The rent deposit of £208,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rental deposit deed | Erstellt am 10. Juni 1998 Geliefert am 19. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the three leases of even date herewtih | |
Kurze Angaben £117,355.47. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TOUCH GROUP PLC Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0