REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03410223 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central House Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| REDSTONE MANAGED SOLUTIONS LIMITED | 07. Nov. 2007 | 07. Nov. 2007 |
| TOLERANT SYSTEMS LTD | 28. Juli 1997 | 28. Juli 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Anthony Barber als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Dean Anthony Barber am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Dean Anthony Barber als Direktor am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Brotherton als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Harneet Jagpal als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Redcentric Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 27. März 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser St John Fisher als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter James Brotherton als Direktor am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter Brotherton als Sekretär am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGPAL, Harneet | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 250197100001 | |||||||
| BROTHERTON, Peter James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 116701310002 | |||||
| BROTHERTON, Peter | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 222049800001 | |||||||
| COLEMAN, Timothy James | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 210014220001 | |||||||
| CROFT, Estelle Louise | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 195008140001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 162493770001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| HWUVEL, Christopher Edward Francis Van Den | Sekretär | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 114731960001 | ||||||
| MYHILL, Paul Harvey | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 175307710001 | |||||||
| O'RORKE, Nicholas | Sekretär | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | 149400410001 | |||||||
| STIGWOOD, Roland Francis Wayne | Sekretär | 23 Brookfield Loggerheads TF9 4RW Market Drayton Salop | British | 46778900001 | ||||||
| TUNSTALL, Nicholas Paul | Sekretär | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | British | 57548240002 | ||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Geschäftsführer | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BARBER, Dean Anthony | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 230739040001 | |||||
| COLEMAN, Timothy James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 163698620001 | |||||
| FISHER, Fraser St John | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 201664700001 | |||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| PERKS, Timothy Howard | Geschäftsführer | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 100207880001 | |||||
| STIGWOOD, Roland Francis Wayne | Geschäftsführer | 23 Brookfield Loggerheads TF9 4RW Market Drayton Salop | British | 46778900001 | ||||||
| TUNSTALL, Lynn | Geschäftsführer | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | England | British | 53939130002 | |||||
| TUNSTALL, Nicholas Paul | Geschäftsführer | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | United Kingdom | British | 57548240002 | |||||
| WEAVER, Anthony Charles | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 153397180001 | |||||
| YAPP, Stephen | Geschäftsführer | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | England | British | 42686850001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcentric Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 06. Juli 2016 | 06. Juli 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Apr. 2015 Geliefert am 08. Apr. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Lease over first and second floor, griffin house, ludgate hill, birmingham. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 05. Dez. 2013 Geliefert am 12. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 08. Apr. 2013 Geliefert am 11. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 21. Juni 2012 Geliefert am 29. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juli 2004 Geliefert am 05. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all specified debts and other debts. By way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2000 Geliefert am 03. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 15. Dez. 1998 Geliefert am 19. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0