CLACTON CENTRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CLACTON CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03415754 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLACTON CENTRE LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich CLACTON CENTRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor Davis House 69-77 High Street CR0 1QE Croydon Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CLACTON CENTRE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LEND LEASE CLACTON LIMITED | 05. Sept. 1997 | 05. Sept. 1997 |
| HACKREMCO (NO.1265) LIMITED | 06. Aug. 1997 | 06. Aug. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLACTON CENTRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CLACTON CENTRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Apr. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Verschiedenes Section 394 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CLACTON CENTRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLISON, Michael Donnavon | Sekretär | 12 Oxford Road HA1 4JQ Harrow Middlesex | British | 102750510001 | ||||||
| SCOTT, Georgina Jane | Geschäftsführer | The Red House 49-53 Clerkenwell Road EC1M 5RS London Flat 10 | England | British | 129107550001 | |||||
| DAVIDSON, Patricia Margaret | Sekretär | 39 Saunderton Vale Saunderton HP14 4LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 38824170008 | ||||||
| GOUGH, Alison Louise | Sekretär | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||
| GOUGH, Alison Louise | Sekretär | 12 Redcliffe Mews SW10 9JU London | Australian | 62074540001 | ||||||
| JORDAN, Jacqueline | Sekretär | 18 Coalbrook Mansions Bedford Hill Balham SW12 9RJ London | British | 88247150001 | ||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Sekretär | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||
| SUTTON, Penelope Ruth | Sekretär | 32 Saxon Road BR1 3RP Bromley Kent | British | 38586070002 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| ARTHUR, Derryn Sue | Geschäftsführer | 21 Elsham Road W14 8HA London | New Zealander | 57726590002 | ||||||
| BURROWS, Roger Leonard | Geschäftsführer | 51 Leyborne Park Kew TW9 3BH Richmond Surrey | Australian | 47271870002 | ||||||
| CAVEN, Robin Graham | Geschäftsführer | 74 St Johns Road TN13 3NB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76216840002 | |||||
| GOUGH, Alison Louise | Geschäftsführer | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||
| MARSHALL, Ian | Geschäftsführer | 43 Belsize Road NW6 4RX London | British | 81232950001 | ||||||
| ROSE, Phillip | Geschäftsführer | 22 West End Lane HA5 1AQ Pinner Middlesex | United Kingdom | Australian | 47271910001 | |||||
| WALICHNOWSKI, Peter | Geschäftsführer | 7 York Avenue East Sheen SW14 7LQ London | Australian | 71829150001 | ||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Hat CLACTON CENTRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of variation of a legal charge dated 28 january 1998 | Erstellt am 20. Dez. 2000 Geliefert am 05. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the borrowers owed or expressed to be owed to the chargee under the loan agreement and/or the security documents and whether owed jointly or severally (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben All that freehold land on the east side of stephenson road, west little, clacton t/no: EX444123; fixed charge money payable under any insurance in respect of the property, assigns the rental income and all right title benefit and interest under any agreement for lease. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation of a debenture dated 2 march 1998 | Erstellt am 20. Dez. 2000 Geliefert am 05. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the partnership or any partner owed or expressed to be owed to the chargee under the loan agreement and/or the security documents and whether owed jointly or severally (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 05. Aug. 1998 Geliefert am 21. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag And varying the terms of a debenture dated 2 march 1998 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 1998 Geliefert am 11. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the ll thi clacton partnership (the "partnership") or any partner owed or expressed to be owed to the chargee under the loan agreement and/or the security documents and whether owed jointly or severally (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 1998 Geliefert am 14. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the company,goodcite limited and clacton investments limited (the borrowers) to the chargee under the loan agreement dated 29 january 1998 and/or the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1998 Geliefert am 03. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the borrowers (as defined) owed or expressed to be owed to the chargee under the loan agreement and the charge and the vendor's initial payment and the vendor's secondary payment (as defined) | |
Kurze Angaben F.h land on the east side of stephenson road west little clacton T.n EX444123 all right title benefit and interest under any agreement for lease. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1998 Geliefert am 31. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, goodcite limited and clacton investments limited (the "borrowers") to the chargee under the loan agreement of even date and the security documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben F/H land on the east sid eof stephenson road west little clacton t/n EX444123, fixed charge interest in money payable under any insurance in respect of the property, assigns the rental income and all right title benefit and interest in or under any agreement for lease. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CLACTON CENTRE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0