FORWARD TRADING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFORWARD TRADING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03416389
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FORWARD TRADING LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich FORWARD TRADING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gorwins House
    119a Hamlet Court Road
    SS0 7EW Westcliff-On-Sea
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORWARD TRADING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für FORWARD TRADING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2020

    3 SeitenAA

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2019

    3 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2017

    2 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016

    3 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2014

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FORWARD TRADING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BIBERFELD, Hindy
    11 Spring Hill
    E5 9BG London
    Sekretär
    11 Spring Hill
    E5 9BG London
    British39374600001
    BIBERFELD, Chaim Michael
    11 Spring Hill
    E5 9BE London
    Geschäftsführer
    11 Spring Hill
    E5 9BE London
    EnglandIsraeli32583270004
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    HALBERSTAM, Sarah
    4910 15th Avenue
    11214
    Brooklyn
    New York
    Usa
    Geschäftsführer
    4910 15th Avenue
    11214
    Brooklyn
    New York
    Usa
    British24954940002
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FORWARD TRADING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Chaim Michael Biberfeld
    119a Hamlet Court Road
    SS0 7EW Westcliff-On-Sea
    Gorwins House
    Essex
    07. Aug. 2016
    119a Hamlet Court Road
    SS0 7EW Westcliff-On-Sea
    Gorwins House
    Essex
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Hat FORWARD TRADING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 06. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All monies held in the rent account.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 06. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house south lambeth road london t/n SGL273204. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 102. Juni 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 105. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 06. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 20. Apr. 2007
    Geliefert am 02. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fosbourne estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house south lambert road london t/no SGL273204 all the plant machinery fixtures and fittings the goodwill the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 07. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from migdal estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house south lambeth road t/no SGL273204 and the proceeds of sale lease or other disposition,all the plant machinery and fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2007
    Geliefert am 07. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from migdal estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12 a victoria house south lambert road t/no SGL273204 the goodwill the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 04. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from migdal estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house, south lambeth road t/n SGL273204. First fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings of the company at the property and all the goodwill affecting the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from finepoint estates limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house south lambeth road t/no SGL273204 the goodwill the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 1A to 12A victoria house south lambeth road t/no SGL273204 all fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Rent charge agreement
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Egt Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Okt. 2001
    Geliefert am 29. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house,lambeth and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north east side of carpenters road sstratford and k/a units 1-6 cearns works 263-267 carpenters road london E15. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1A to 12A victoria house south lambeth road london SW8 t/no;-SGL273204 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plany andd machinery goodwill and the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16,22,24,26 and 28 westerham avenue london N9 9BU t/no;-NGL396178 NGL211648 SGL273204 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on the property with goodwill and the benefit of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 03. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 03. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Specific property being 1). 1A to 12A victoria house south lambeth road london t/no;-SGL273204 2). land and buildings on the north side of carpenters road stratford and k/a units 1-6 caerns works 263-267 carpenters road london E15 t/no;-egl 154166 3). 16,22,24,26 and 28 westerham avenue london N9 t/no's;-NGL396178, NGL211648 and SGL273204. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 29. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge its undertaking and all its property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Berechtigte Personen
    • Gladstar Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 29. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a 1A to 12A victoria house south lambeth road.t/no.SGL273204.all that f/h property k/a 16 westerham avenue edmonton.t/no.NGL396178.all that f/h property k/a 26 & 28 westerham avenue edmonton.t/no.NGL396179 for further details of property charged please refer to for M395.together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gladstar Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FORWARD TRADING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Simon Paul Davidson
    33 Wigmore Street
    WIU 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    WIU 1BZ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0