CIVICA IT SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CIVICA IT SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03417245 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SANDERSON SYSTEMS LIMITED | 01. Okt. 1997 | 01. Okt. 1997 |
| BROOMCO (1334) LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Downing am 04. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Phillip David Rowland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Stoddard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CIVICA IT SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STODDARD, Michael | Sekretär | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | British | 72002400004 | ||||||
| DOWNING, Simon Richard | Geschäftsführer | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London | England | British | 95005230002 | |||||
| ROWLAND, Phillip David | Geschäftsführer | Burston Road Putney SW15 6AR London 2 | United Kingdom | British | 147804610001 | |||||
| FROST, Adrian David | Sekretär | 2 Edwards Road B75 5NG Sutton Coldfield West Midlands | British | 74874640001 | ||||||
| NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle | Sekretär | Woodford Lodge Ramsden Road GU7 1QE Godalming Surrey | British | 29772430003 | ||||||
| STEWART, Caroline Elizabeth | Sekretär | 17 Priest Meadow Close Astwood Bank B96 6HT Redditch Worcestershire | British | 52912910002 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BEER, Peter James | Geschäftsführer | 9 High Ash Crescent LS17 8RP Leeds Yorkshire | England | British | 56245440001 | |||||
| DEWIS, Brian John | Geschäftsführer | Wychend Grange Road SL6 9RW Cookham Berkshire | England | British | 30266880002 | |||||
| HODKINSON, Allan Leslie | Geschäftsführer | 195 Foley Road West Streetly B74 3NX Sutton Coldfield West Midlands | British | 21839900001 | ||||||
| KENDRICK-ASTLE, Pamela Elizabeth | Geschäftsführer | 105 Brambling, Wilnecote B77 5PG Tamworth Staffordshire | British | 65220350001 | ||||||
| NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle | Geschäftsführer | Woodford Lodge Ramsden Road GU7 1QE Godalming Surrey | United Kingdom | British | 29772430003 | |||||
| STEWART, Caroline Elizabeth | Geschäftsführer | 17 Priest Meadow Close Astwood Bank B96 6HT Redditch Worcestershire | British | 52912910002 | ||||||
| STODDARD, Michael | Geschäftsführer | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | England | British | 72002400004 | |||||
| WATSON, David John | Geschäftsführer | 151 High Street OX44 7ST Chalgrove Oxfordshire | British | 45073610001 | ||||||
| WINN, Christopher | Geschäftsführer | Willow Bank Halls Farm Lane Trimpley DY12 1NP Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 15932260001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat CIVICA IT SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee) | Erstellt am 10. März 2000 Geliefert am 21. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 1999 Geliefert am 17. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 1997 Geliefert am 01. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CIVICA IT SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0