COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED

COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03422275
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    • Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (10890) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mary Street House
    Mary Street
    TA1 3NW Taunton
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Okt. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:resolution re: liquidators authority
    1 SeitenLIQ MISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Juni 2017

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Whiteoaks Farm the Old Sidings Corsham Road Lacock Wiltshire SN15 2LZ zum Mary Street House Mary Street Taunton TA1 3NW am 21. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 01. Okt. 2016

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Geschäftsführer am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Sekretär am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    7 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034222750009 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034222750010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034222750008 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034222750011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 03. Okt. 2015

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 034222750011, erstellt am 18. Apr. 2016

    35 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 034222750010, erstellt am 18. Apr. 2016

    10 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Adrian David Gott als Direktor am 18. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Sept. 2014

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 034222750009, erstellt am 30. Mai 2015

    10 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOTT, Adrian David
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish111647120004
    HOWMAN, William Angia
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    Sekretär
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    British46577370001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Sekretär
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    SHEPPARD, James David
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    Sekretär
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    147723070001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Sekretär
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Sekretär
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    BOWEN-THOMAS, Peter
    Willowdene
    Wades Way Trunch
    NR28 0PW North Walsham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Willowdene
    Wades Way Trunch
    NR28 0PW North Walsham
    Norfolk
    British21384770001
    CANNOCK, Richard Jeffrey
    26 Rupert Road
    RG14 7EL Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    26 Rupert Road
    RG14 7EL Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish172177850002
    HOWMAN, William Angia
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    EnglandBritish46577370001
    KENT, Michael Richard John
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    British67069980001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Geschäftsführer
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    ROGERS, Nicholas Ian
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    British42807600003
    SHEPPARD, James David
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish123411450001
    VERGERSON, Jeffrey Vernon
    Hillside View
    Foxham
    SN15 4NL Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Hillside View
    Foxham
    SN15 4NL Chippenham
    Wiltshire
    British78318120001
    VERGERSON, Julie Elizabeth
    18 Windsor Park
    NR19 2SU Dereham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    18 Windsor Park
    NR19 2SU Dereham
    Norfolk
    British52412280001
    WATTS, David
    Half Acre Stowhill
    Childrey
    OX12 9XQ Wantage
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Half Acre Stowhill
    Childrey
    OX12 9XQ Wantage
    Oxfordshire
    British13082830001
    WHITE, Brian Keith
    35 St Johns Road
    Grove
    OX12 7NP Wantage
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    35 St Johns Road
    Grove
    OX12 7NP Wantage
    Oxfordshire
    British31415220001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Thames Valley Fooods
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    06. Apr. 2016
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEanland And Wales
    Registrierungsnummer02751833
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 28. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pamela Jane Corbett
    • Richard Gerard Heaton Corbett
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 21. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 04. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 03. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each company with full title guarantee hereby charges its credit balances to the bank to secure repayment of the secured obligations.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 29. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter with endorsement
    Erstellt am 22. Juni 1998
    Geliefert am 25. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The performance of the company's obligations due to the chargee under a lease dated 22 june 1998 and any of the other obligations of the company to the chargee
    Kurze Angaben
    £1000 being the deposited sum and interest earned thereon and all money from time to time appropriated by the chargee therefrom in accordance with the said letter.
    Berechtigte Personen
    • Breckland District Council
    Transaktionen
    • 25. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 1997
    Geliefert am 02. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Okt. 2018Aufgelöst am
    30. Juni 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laurence George Russell
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset
    Praktiker
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0