PII GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PII GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03424318 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PII GROUP LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich PII GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Northumberland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PII GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 23. Feb. 1998 | 23. Feb. 1998 |
| 2040TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 12. Feb. 1998 | 12. Feb. 1998 |
| 2040TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 22. Aug. 1997 | 22. Aug. 1997 |
| PIPELINE INTEGRITY INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 22. Aug. 1997 | 22. Aug. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PII GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2025 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PII GROUP LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Mai 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Mai 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Mai 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PII GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 125 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 129 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 135 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kristopher Ryan Mcbride als Geschäftsführer am 11. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ United Kingdom zum 10th Floor 245 Hammersmith Road London W6 8PW geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Sanjeet Chadda am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 139 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 263 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Al-Shaheen Energy Services Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 14. Aug. 2020 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Lorraine Amanda Dunlop als Sekretär am 20. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom zum The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Andrew Hamilton als Sekretär am 09. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 50 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PII GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP, Lorraine Amanda | Sekretär | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland | 266579350001 | |||||||||||
| BELLAMY, Michael | Geschäftsführer | Atley Way North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Ge Oil & Gas, Pii Pipeline Solutions Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 76315930001 | |||||||||
| CHADDA, Sanjeet | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland | United Kingdom | British | 116527050006 | |||||||||
| CONE, Harry Douglas | Sekretär | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||||||
| GRAHAM, William | Sekretär | 23 Pinegarth Darras Hall NE20 9LF Ponteland Northumberland England | British | 59156580001 | ||||||||||
| HAMILTON, John Andrew | Sekretär | c/o Ge Oil & Gas Pii Pipeline Solutions North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | British | 157793400001 | ||||||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Sekretär | 24 Mayfield Road Gosforth NE3 4HE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 32519770002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||||||
| EXCELLET INVESTMENTS LIMITED | Sekretär | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London | 1872620003 | |||||||||||
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | 26-28 Market Street WA14 1PF Altrincham Webber House Cheshire |
| 146358090001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38545840001 | |||||||||||
| SISEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| ACKHURST, Trent Braden | Geschäftsführer | Hollyhurst Hepscott NE61 6LX Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | 120742460001 | |||||||||
| AL-MAHMOUD, Meshaal Mohamed | Geschäftsführer | Al Sadd Street 70 Doha Al Sadd Building Qatar | Qatar | Qatari | 171831540001 | |||||||||
| AL-MANA, Ali Abdulla | Geschäftsführer | West Bay PO BOX 3212 Doha World Trade Center Qatar | Qatar | Qatari | 202014590001 | |||||||||
| AL-MOHANNADI, Said Mubarak Said | Geschäftsführer | Area 32 Madinat Khalifa North Doha Villa No 14 Altaif Street Qatar | Qatar | Qatari | 155231000001 | |||||||||
| AL-MUHANNADI, Saad Rashid Mohammed | Geschäftsführer | Al-Khubaib Street Doha Al-Handasa 00974 Qatar | Qatar | Qatari | 178078260001 | |||||||||
| AL-SHABI, Abdulrahman Ahmad Abdulrahman | Geschäftsführer | Qatar Petroleum 70 Al-Saad Doha Finance Department | Qatar | Qatari | 155231350001 | |||||||||
| AL-SULAITI, Ahmad Saif Ahmad | Geschäftsführer | Qatar Petroleum Box 100001 Dukhan Operations Department Qatar | Qatar | Qatari | 155231550001 | |||||||||
| BATHGATE, Adam | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 124847880001 | |||||||||
| BELLAMY, Michael | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland | United Kingdom | British | 76315930001 | |||||||||
| BERGER, Christopher Carl | Geschäftsführer | 56 Percy Park NE30 4JX Tynemouth Tyne & Wear | American | 122240370001 | ||||||||||
| BERTONI, Fernando | Geschäftsführer | Via Felice Matteucci 2 FOREIGN Florence Nuovo Pignone S.P.A. 50127 Italy | Italian | British | 154009290001 | |||||||||
| BUCANEVE, Giovanni | Geschäftsführer | Via Della Chiesa 24 FOREIGN Florence 50125 Italy | Italian | 81347380001 | ||||||||||
| BUCCI, John Vincent | Geschäftsführer | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | American | 124762710001 | ||||||||||
| CARTLEDGE, Andrew | Geschäftsführer | 30 Trailside Road MA 02493 Weston United States | British | 70072110003 | ||||||||||
| CHRISTIE, Roderick Angus | Geschäftsführer | 14 Oakfield Road SL8 5QN Bourne End Buckinghamshire | British | 82543780001 | ||||||||||
| CLARK, Alyson Margaret | Geschäftsführer | 13 Heron's Place TW7 7BE Old Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | 56868460002 | |||||||||
| DANIEL, Paul Nigel | Geschäftsführer | 7 Lucerne Drive Stadhampton OX44 7QT Oxford Oxfordshire | British | 84264310001 | ||||||||||
| DE MARCHIS, Ranieri | Geschäftsführer | Via Delle Campora 36 FOREIGN Florence 50124 Italy | Italian | 81347480001 | ||||||||||
| DE SMEDT, Raymond Andre | Geschäftsführer | Apartment G 48 Berkeley Square W1X 5DB London | Belgian | 62590370001 | ||||||||||
| DIGBY, Mark Damien | Geschäftsführer | Calle Valle Del Roncal 71, Las Lomas 28660 Boadilla Del Monte Madrid Spain | Irish | 103125610001 | ||||||||||
| GRAHAM, William | Geschäftsführer | The Coach House Shortridge Hall NE64 0XU Warkworth Northumberland | British | 59156580005 | ||||||||||
| GREEN, Charles Edward Seager | Geschäftsführer | 32 Mayford Road SW12 8SD London | British | 60651100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PII GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Shaheen Energy Services Limited | 06. Apr. 2016 | North Nelson Industrial Estate NE23 1WW Cramlington Atley Way Northumberland United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PII GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 09. Mai 2017 | 14. Aug. 2020 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0