LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03425487 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Santia House Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Mid Glamorgan Wales |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| T J LOWE ENGINEERING SERVICES LIMITED | 18. Juli 2002 | 18. Juli 2002 |
| KAM SERVICES (U.K.) LIMITED | 27. Aug. 1997 | 27. Aug. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Carlisle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Wells als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF am 01. Dez. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Francis Wells am 02. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Ernennung von Julia Cavanagh als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ian Carlisle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Prowse als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 10 Seiten | 395 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 14 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVANAGH, Julia | Sekretär | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 146903970001 | ||||||
| NADIN, Rosalind Claire | Sekretär | 21 Pembroke Avenue DN4 8HF Doncaster South Yorkshire | British | 66390150001 | ||||||
| PHILLIPS, Jackey | Sekretär | 6 Mount Pleasant Avenue EX8 4QD Exmouth Devon | British | 104367080001 | ||||||
| ROEBUCK, Richard Paul | Sekretär | 47 Broom Avenue S60 3NG Rotherham South Yorkshire | British | 127690470001 | ||||||
| ROWAN, Karen | Sekretär | 122 Airedale Road S6 4AW Sheffield South Yorkshire | British | 64957750001 | ||||||
| WELLS, David Francis | Sekretär | Ashley SN13 8AJ Near Box Ashley Farmhouse Wiltshire England | British | 104366980002 | ||||||
| WIGGETT, Robert Paul | Sekretär | 56 Wickett Hern Road Armthorpe DN3 3SR Doncaster South Yorkshire | British | 38437380001 | ||||||
| CARLISLE, Ian | Geschäftsführer | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | England | British | 146715900001 | |||||
| EASON, Richard John | Geschäftsführer | 9 Westfield Gardens Kippax LS25 7JB Leeds West Yorkshire | England | British | 92940610001 | |||||
| FAIRCLOUGH, Peter Michael | Geschäftsführer | 93 Wheatcroft Road Rawmarsh S62 5EF Rotherham South Yorkshire | British | 62144490001 | ||||||
| GRIFFITHS, Andrew Graham | Geschäftsführer | 1 Heron Court Conisbrough DN12 3QL Doncaster | England | British | 84870080002 | |||||
| HAWKE, David | Geschäftsführer | 72c Station Road Hatfield DN7 6QL Doncaster South Yorkshire | British | 38437320001 | ||||||
| KIRK, Matthew Craig | Geschäftsführer | 11 Empire Drive Maltby S66 8SL Rotherham South Yorkshire | British | 76469510001 | ||||||
| LOWE, Terence James | Geschäftsführer | 3 Pear Tree Close S81 8SJ Worksop Lindum House Nottinghamshire | British | 133991120001 | ||||||
| MALSON, Andrew | Geschäftsführer | 2 Pinfold Lane Misterton DN10 4FE Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 105274120001 | |||||
| PROWSE, John | Geschäftsführer | 317 Ongar Road CM15 9HP Brentwood Essex | England | British | 96786510001 | |||||
| TURNER, Robert James | Geschäftsführer | 1 Lansdowne Crescent Swinton S64 8TW Mexborough South Yorkshire | British | 69568650001 | ||||||
| WELLS, David Francis | Geschäftsführer | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | United Kingdom | British | 104366980002 | |||||
| WIGGETT, Barry | Geschäftsführer | 17 Peck Mill View Kiveton Park Station S26 6UY Sheffield South Yorkshire | British | 72943450001 | ||||||
| WIGGETT, Robert Paul | Geschäftsführer | 56 Wickett Hern Road Armthorpe DN3 3SR Doncaster South Yorkshire | British | 38437380001 |
Hat LOWE GROUP (ENGINEERING) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 06. Aug. 2009 Geliefert am 25. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 10. Juli 2009 Geliefert am 23. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 28. Mai 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Nov. 2000 Geliefert am 01. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Sept. 2000 Geliefert am 16. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 06. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0