BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBTL REALISATIONS 2009 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03425946
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    • (5190) /

    Wo befindet sich BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BERTRAM TRADING LIMITED05. Juli 200505. Juli 2005
    CYPHER HOLDINGS LIMITED05. Mai 200005. Mai 2000
    CYPHER GROUP LIMITED21. Aug. 199721. Aug. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Feb. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2011

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 11. März 2011

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2010

    10 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2010

    12 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2009

    12 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    47 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    46 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed bertram trading LIMITED\certificate issued on 23/03/09
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 02. Feb. 2008

    25 SeitenAAMD

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Feb. 2008

    25 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    6 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07
    capital

    Beschlüsse

    Authority to execute documents 29/08/2008
    RES13

    legacy

    8 Seiten155(6)a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEEMING, Christopher
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish83952290001
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Sekretär
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    British75314100001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Sekretär
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    MCGONIGLE, Richard John
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    Sekretär
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    British125002440001
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Sekretär
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    ROBINSON, Michael John
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    British60420200003
    VERSEC SECRETARIES LIMITED
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    79043790001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARNETSON, Graham
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    United KingdomBritish94018550003
    BROWN, Thomas Henry Phelps
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritish4055550001
    ENGLISH, Paul Robert Forster
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    British48135660002
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Geschäftsführer
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    United KingdomBritish75314100001
    GRAY, Raymond John
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    British58316960001
    HENDRIE, Ian Arthur
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    Geschäftsführer
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    United KingdomBritish123762920001
    HORRY, David
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    Geschäftsführer
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    United KingdomBritish95866490004
    HOWARD, Josephine Mary
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish94643210001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    LEWIS, Stephen Bernard
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    Geschäftsführer
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    United KingdomBritish78249540002
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Geschäftsführer
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    NEIL, Michael Hugh
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    Geschäftsführer
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    United KingdomBritish129915950001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish95086050001
    REILLY, Terence Michael
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88886600001
    ROBINSON, Michael John
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    EnglandBritish115823780001
    WIGGLESWORTH, Lloyd John
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    Geschäftsführer
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    EnglandBritish128029980001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat BTL REALISATIONS 2009 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2008
    Geliefert am 03. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Book debts debenture
    Erstellt am 27. März 2007
    Geliefert am 04. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge all purchased debts together with their related rights,and by way of floating charge the other debts together with their related rights and such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2005
    Geliefert am 18. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and buildings at enfield road, morley, leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2001
    Geliefert am 30. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any member of the group (as defined) to the chargee as security trusteee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") whether pursuant to the a loan note instrument, the b loan note instrument, the a notes, the b notes, the guarantee (all as defined) or otherwise on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rowan Nominees Limited
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 17. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) whether pursuant to the loan note instrument, the notes, guarantee or otherwise
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rowan Nominees Limited
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 10. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policies and all monies including bonuses accrued or which may at any time accrue which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 10. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all debts (purchased or to be purchased by the security holder pursuant to the agreement) which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (as defined) pertaining to such debts and floating charge all undertaking property rights and assets of the company present and future present and future stock in trade uncalled capital not charged by way of fixed charge above.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a subscription agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Development Capital Limited (As Security Trustee for Itself and the Investors)
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BTL REALISATIONS 2009 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. März 2011Ende der Verwaltung
    20. März 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0