COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD
Überblick
| Unternehmensname | COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03426633 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
- Aktivitäten von Berufsverbänden (94120) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rossington's Business Park West Carr Road DN22 7SW Retford Nottinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COBRA CAPITAL RELEASE LIMITED | 19. Feb. 2008 | 19. Feb. 2008 |
| BKG MORTGAGES LIMITED | 27. Juli 2002 | 27. Juli 2002 |
| BKG PROPERTIES LIMITED | 22. Nov. 2001 | 22. Nov. 2001 |
| BURROWS KEITH PROPERTIES LIMITED | 29. Aug. 1997 | 29. Aug. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Redgwell am 13. Jan. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Carl Lloyd Mcmillan als Direktor am 13. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Gavin Matthew Perkins als Direktor am 13. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Steven Redgwell als Direktor am 13. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Brendan James Mcmanus als Geschäftsführer am 13. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ryan Christopher Brown als Geschäftsführer am 13. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 96 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Bowler als Geschäftsführer am 09. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 88 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Change of details for Cobra Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Cobra Holdings Ltd as a person with significant control on 22. Aug. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2020 bis 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||
Beendigung der Bestellung von David George Edward Stanley als Geschäftsführer am 01. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMILLAN, Carl Lloyd | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 291243280001 | |||||
| PERKINS, Gavin Matthew | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire United Kingdom | England | British | 291367680001 | |||||
| REDGWELL, Steven | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire United Kingdom | England | British | 226334320002 | |||||
| BOWLER, Michael | Sekretär | Morley Road Sanderstead CR2 0EN South Croydon 28 Surrey | British | 13539620002 | ||||||
| DIXON, Janet Bryan | Sekretär | Las Mercedes 32 Twinoaks KT11 2QP Cobham Surrey | British | 30326330001 | ||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Thames House Portsmouth Road KT10 9AD Esher Surrey | 34893920004 | |||||||
| WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 1st Floor Curzon House 24 High Street SM7 2LJ Banstead Surrey | 111052920001 | |||||||
| BOWLER, Michael | Geschäftsführer | Morley Road CR2 0EN South Croydon 28 Surrey England | England | British | 13539620002 | |||||
| BOWLER, Michael | Geschäftsführer | Morley Road Sanderstead CR2 0EN South Croydon 28 Surrey | England | British | 13539620002 | |||||
| BRIGHT, Peter John | Geschäftsführer | Buckingham Way SM6 9LU Wallington 55 Surrey | England | British | 110864550001 | |||||
| BROWN, Ryan Christopher | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire | United Kingdom | British | 287066760001 | |||||
| BURROWS, Stephen Mark | Geschäftsführer | Firdale East Parkside Great Park CR6 9PZ Warlingham Surrey | United Kingdom | British | 13539590001 | |||||
| KEITH, Colin Reginald | Geschäftsführer | Heath Cottage Colley Lane RH2 9DD Reigate Surrey | British | 13539600001 | ||||||
| MCMANUS, Brendan James | Geschäftsführer | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire | United Kingdom | British | 128122260001 | |||||
| POULTON, Hannah | Geschäftsführer | 6 Daines Way SS1 3PF Southend On Sea Essex | British | 99706350001 | ||||||
| SAUNDERS, Stephen David | Geschäftsführer | 103 Oval Road CR0 6BR Croydon Surrey | England | British | 83911420001 | |||||
| STANLEY, David George Edward | Geschäftsführer | 12 Court Meadow Close TN6 3LW Rotherfield East Sussex | England | British | 79784840001 | |||||
| VERRELL, Rose Elizabeth | Geschäftsführer | 46 Arundel Avenue CR2 8BB South Croydon Surrey | British | 47301700001 | ||||||
| WALLIS, Lee Grant | Geschäftsführer | 10 Chaucer Close SM7 1PP Banstead Surrey | England | British | 27309640002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. März 2015 Geliefert am 26. März 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Sept. 2012 Geliefert am 22. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Feb. 2009 Geliefert am 26. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a guarantee and debenture | Erstellt am 19. Jan. 2009 Geliefert am 09. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 9-11 high street, alton, hampshire t/no SH12795, f/h property k/a 139 and 141 manchester road, broadheath, altrincham, cheshire t/no GM768625 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Jan. 2009 Geliefert am 31. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other charging company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. März 1998 Geliefert am 30. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 49 woodpecker mount and garage 55 addington L.B. of croydon t/n-SGL587114.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Dez. 1997 Geliefert am 08. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 63 bellfield addington london borough of croydon t/no: SGL171383. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0