WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03428877 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Lkab Minerals Limited Raynesway DE21 7BE Derby England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALEXCREST LIMITED | 03. Sept. 1997 | 03. Sept. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Mark Wheatley als Sekretär am 16. Aug. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Miss Lisa Jane Newbold als Sekretär am 16. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 18 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 30. Juni 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Lkab Minerals Limited as a person with significant control on 27. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 10 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von David Thomas Balch als Geschäftsführer am 28. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the White House Gurney Slade Radstock Radstock BA3 4UU zum C/O Lkab Minerals Limited Raynesway Derby DE21 7BE am 14. Dez. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2019 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Ernennung von Mr Richard Mark Wheatley als Sekretär am 03. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Erfüllung der Belastung 034288770009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Ernennung von Mr Darren Anthony Wilson als Direktor am 03. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Adrian Howard Willmott als Geschäftsführer am 03. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jane Symonds Willmott als Geschäftsführer am 03. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Notification of Lkab Minerals Limited as a person with significant control on 03. Dez. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Adrian Howard Willmott as a person with significant control on 03. Dez. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2018 | 11 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 10 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWBOLD, Lisa Jane | Sekretär | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | 286278450001 | |||||||
| WILSON, Darren Anthony | Geschäftsführer | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | England | British | 183267820001 | |||||
| ASTLEY, Stephen | Sekretär | Overnhill Road BS16 5DN Downend 18 Bristol | British | 130826850001 | ||||||
| LUMBER, Nicholas, Acma | Sekretär | 20 Compton Road BA4 5QR Shepton Mallet Somerset | British | 55404740001 | ||||||
| WHEATLEY, Richard Mark | Sekretär | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | 253101350001 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ASTLEY, Stephen | Geschäftsführer | Overnhill Road BS16 5DN Downend 18 Bristol | England | British | 130826850001 | |||||
| BALCH, David Thomas | Geschäftsführer | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House England | England | British | 199358570001 | |||||
| LUMBER, Nicholas, Acma | Geschäftsführer | 20 Compton Road BA4 5QR Shepton Mallet Somerset | British | 55404740001 | ||||||
| SMITH, David Peter | Geschäftsführer | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House Somerset United Kingdom | United Kingdom | British | 123036790012 | |||||
| SYMONDS WILLMOTT, Jane | Geschäftsführer | c/o The White House Radstock BA3 4UU Radstock Gurney Slade United Kingdom | England | British | 115812240003 | |||||
| WILLMOTT, Adrian Howard | Geschäftsführer | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House Somerset United Kingdom | England | British | 18773770004 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lkab Holdings (Uk) Limited | 03. Dez. 2018 | Raynesway DE21 7BE Derby Mica Works England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Adrian Howard Willmott | 06. Apr. 2016 | c/o THE WHITE HOUSE Radstock BA3 4UU Radstock Gurney Slade | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. Juli 2015 Geliefert am 03. Aug. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The freehold land being euston lime, stretham road, wicken, ely, CB75XL registered at the land registry with title number CB207528. Please see charge for details of further properties. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Feb. 2010 Geliefert am 20. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Juni 2006 Geliefert am 01. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the north of dimmock's cote road wicken cambridgeshire t/no's CB207528 and CB264899. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Mai 2006 Geliefert am 20. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 25. Apr. 2006 Geliefert am 04. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2004 Geliefert am 22. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 16. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/Hh property k/a land to the north of dimmocks cote road wicken cambridgeshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 2001 Geliefert am 29. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1997 Geliefert am 02. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 and all other monies de or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One saxi frage mill id no. SAXIBMBF01 all accesories component parts improvements renewals all books manuals technical data drawings schedules and other documentation and any amendment thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0