LLNH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLLNH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03429499
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LLNH LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich LLNH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LLNH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEND LEASE NH LIMITED07. Jan. 199807. Jan. 1998
    LEND LEASE HOMES LIMITED11. Sept. 199711. Sept. 1997
    HACKREMCO (NO.1266) LIMITED04. Sept. 199704. Sept. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LLNH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für LLNH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2020

    9 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 034294990011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034294990012 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 034294990013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 034294990014, erstellt am 27. Apr. 2021

    57 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 034294990015, erstellt am 27. Apr. 2021

    216 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 034294990016, erstellt am 27. Apr. 2021

    90 SeitenMR01

    Ernennung von Mr James Walter Tugendhat als Direktor am 14. Sept. 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James Justin Hutchens als Geschäftsführer am 05. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Justin Hutchens am 08. Jan. 2018

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Chaitanya Bhupendra Patel als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr James Justin Hutchens als Direktor am 21. Sept. 2017

    2 SeitenAP01

    Erfüllung der Belastung 034294990010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 034294990013, erstellt am 30. Juni 2017

    47 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von LLNH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish218306870001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Sekretär
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Sekretär
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Sekretär
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Sekretär
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Sekretär
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Sekretär
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Sekretär
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Sekretär
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    SUTTON, Penelope Ruth
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    Sekretär
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    British38586070002
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ARTHUR, Derryn Sue
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    Geschäftsführer
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    New Zealander57726590002
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Geschäftsführer
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Geschäftsführer
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Geschäftsführer
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    BURROWS, Roger Leonard
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Australian47271870002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Geschäftsführer
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Geschäftsführer
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Geschäftsführer
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Geschäftsführer
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Geschäftsführer
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Geschäftsführer
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    MARSHALL, Ian
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    Geschäftsführer
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    British81232950001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Geschäftsführer
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Geschäftsführer
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LLNH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    01. Mai 2017
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    Nein
    RechtsformLimited
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer02798607
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat LLNH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 27. Apr. 2021
    Geliefert am 29. Apr. 2021
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Apr. 2021
    Geliefert am 29. Apr. 2021
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Apr. 2021
    Geliefert am 29. Apr. 2021
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juni 2017
    Geliefert am 10. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 10. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juni 2017
    Geliefert am 07. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 07. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juni 2017
    Geliefert am 06. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 06. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Nov. 2014
    Geliefert am 21. Nov. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hcp, Inc. (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Juli 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security deed
    Erstellt am 15. Jan. 2007
    Geliefert am 30. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, London Branch
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2006
    Geliefert am 21. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2005
    Geliefert am 20. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2005
    Geliefert am 15. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 11. Juni 1998
    Geliefert am 18. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage f/h interest in aberford hall nursing home oakwood green roundhay leeds LS8 2QU t/n-WYK510482, ascot lodge nursing home 48A newlands road intake sheffield S12 2FZ t/n-SYK354711, aston house nursing home 26 angel lane hayes middlesex UB3 2QX t/n-NGL47781 (see 395 for other properties charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transaktionen
    • 18. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 03. Juni 1998
    Geliefert am 08. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability that the obligors (as therein defined) may have to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined in the facility agreement dated 28 january 1998) (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998)
    Kurze Angaben
    The f/h interest in the property k/a ashton grange residential home st lukes road pallion sunderland t/n TY304629, windsor court bartholomew avenue goole east riding of yorkshire t/n HS170159, ashbourne lodge nursing home ryhope road grangetown sunderland t/n TY310171 and victoria house residential home bath lane stockton on tees t/n CE136807 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 08. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture made between (1) llnhp partnership acting through its partners (2) nhp securities no.4 Limited and (3) lend lease nh limited in favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee
    Erstellt am 06. Mai 1998
    Geliefert am 11. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Kurze Angaben
    All rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property k/a the beeches nursing home 55 furlong road arnold nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1998
    Geliefert am 24. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the obligors (as therein defined) have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum now or hereafter owing due or incurred by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Kurze Angaben
    All rights and claims in relation to the real property being - the f/h ladymead nursing home canal way devizes wiltshire t/n WT133199 avonmead nursing home canal way devises wiltshire t/n's WT132231, WT142939 and WT154929 and kingsmead nursing home prospect place old town swindon wiltshire t/n's WT16064, WT139496 and WT137926. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandthe "Security Trustee"
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 1998
    Geliefert am 03. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the obligors (as defined) have to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum at the date of the debenture or thereafter owing by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Kurze Angaben
    A.the real property other than scottish real property and the northern irish real property;B.all rights and claims to which llnhp and each partner is at the date of the debenture or may thereafter become entitled in relation to all monies at the date of the debenture or at any time standing to the credit of any bank accounts.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0