LLNH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LLNH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03429499 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LLNH LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich LLNH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House Archer Street DL3 6AH Darlington County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LLNH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LEND LEASE NH LIMITED | 07. Jan. 1998 | 07. Jan. 1998 |
| LEND LEASE HOMES LIMITED | 11. Sept. 1997 | 11. Sept. 1997 |
| HACKREMCO (NO.1266) LIMITED | 04. Sept. 1997 | 04. Sept. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LLNH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LLNH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 034294990011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 034294990012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 034294990013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034294990014, erstellt am 27. Apr. 2021 | 57 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034294990015, erstellt am 27. Apr. 2021 | 216 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034294990016, erstellt am 27. Apr. 2021 | 90 Seiten | MR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Walter Tugendhat als Direktor am 14. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Justin Hutchens als Geschäftsführer am 05. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Justin Hutchens am 08. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Chaitanya Bhupendra Patel als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Justin Hutchens als Direktor am 21. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 034294990010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034294990013, erstellt am 30. Juni 2017 | 47 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LLNH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Sekretär | Flat 1 Basement 269 Magdalen Road Earlsfield SW18 3NZ London | British | 106745220001 | ||||||
| GOUGH, Alison Louise | Sekretär | 12 Redcliffe Mews SW10 9JU London | Australian | 62074540001 | ||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Sekretär | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
| KAUL, Sheila | Sekretär | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
| KILMARTIN, Adrian Robert | Sekretär | Church Farm Acton Turville GL9 1HD Badminton South Gloucestershire | British | 11660010001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | 110640170001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | 110640170001 | ||||||
| MORTIMER, Rachel | Sekretär | 14 Huron Road SW17 8RB London | British | 102674500002 | ||||||
| PANG, Lily | Sekretär | Calbourne Road SW12 8LW London 9 United Kingdom | Malaysian | 140239060001 | ||||||
| SUTTON, Penelope Ruth | Sekretär | 32 Saxon Road BR1 3RP Bromley Kent | British | 38586070002 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| ARTHUR, Derryn Sue | Geschäftsführer | 21 Elsham Road W14 8HA London | New Zealander | 57726590002 | ||||||
| AUBERY, Paul Richard | Geschäftsführer | 1 Malthouse Drive Regency Quay Chiswick W4 2NR London | British | 78253140001 | ||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | 94259330002 | |||||
| BLITZER, David Scott | Geschäftsführer | 5 Priory Walk SW10 9SP London | England | American | 82685720001 | |||||
| BURROWS, Roger Leonard | Geschäftsführer | 51 Leyborne Park Kew TW9 3BH Richmond Surrey | Australian | 47271870002 | ||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Geschäftsführer | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| DAVIES, William Jeremy | Geschäftsführer | The Manor House Great Somerford SN15 5EH Chippenham Wiltshire | England | British | 21505070001 | |||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Geschäftsführer | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| ELLERT, Richard John | Geschäftsführer | Cami Del Padro 10 Sant Vicenc De Montalt Barcelona Catalonia 08394 Spain | British | 95944260001 | ||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Geschäftsführer | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||
| FRANCIS, Daniel Fernley | Geschäftsführer | Bartley Lodge 11 Marlborough Road Chandlers Ford SO53 5DJ Eastleigh Hampshire | England | British | 44830480001 | |||||
| GOUGH, Alison Louise | Geschäftsführer | 12 Redcliffe Mews SW10 9JU London | Australian | 62074540001 | ||||||
| GRANT, Michael John | Geschäftsführer | Edwill Way BR3 6RY Beckenham 73 Kent | England | British | 141668610001 | |||||
| HUTCHENS, James Justin | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | United Kingdom | American | 238334580002 | |||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Geschäftsführer | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||
| MARSHALL, Ian | Geschäftsführer | 43 Belsize Road NW6 4RX London | British | 81232950001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | 110640170001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | 110640170001 | |||||
| MOY, Neal St John | Geschäftsführer | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LLNH LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhp Limited | 01. Mai 2017 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House Durham England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LLNH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 29. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 29. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 29. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 10. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 07. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 06. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Nov. 2014 Geliefert am 21. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security deed | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 30. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 11. Juni 1998 Geliefert am 18. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture) | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage f/h interest in aberford hall nursing home oakwood green roundhay leeds LS8 2QU t/n-WYK510482, ascot lodge nursing home 48A newlands road intake sheffield S12 2FZ t/n-SYK354711, aston house nursing home 26 angel lane hayes middlesex UB3 2QX t/n-NGL47781 (see 395 for other properties charged).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 03. Juni 1998 Geliefert am 08. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability that the obligors (as therein defined) may have to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined in the facility agreement dated 28 january 1998) (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) | |
Kurze Angaben The f/h interest in the property k/a ashton grange residential home st lukes road pallion sunderland t/n TY304629, windsor court bartholomew avenue goole east riding of yorkshire t/n HS170159, ashbourne lodge nursing home ryhope road grangetown sunderland t/n TY310171 and victoria house residential home bath lane stockton on tees t/n CE136807 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture made between (1) llnhp partnership acting through its partners (2) nhp securities no.4 Limited and (3) lend lease nh limited in favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee | Erstellt am 06. Mai 1998 Geliefert am 11. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture) | |
Kurze Angaben All rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property k/a the beeches nursing home 55 furlong road arnold nottingham. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 10. Feb. 1998 Geliefert am 24. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability which the obligors (as therein defined) have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum now or hereafter owing due or incurred by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Kurze Angaben All rights and claims in relation to the real property being - the f/h ladymead nursing home canal way devizes wiltshire t/n WT133199 avonmead nursing home canal way devises wiltshire t/n's WT132231, WT142939 and WT154929 and kingsmead nursing home prospect place old town swindon wiltshire t/n's WT16064, WT139496 and WT137926. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 1998 Geliefert am 03. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability which the obligors (as defined) have to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum at the date of the debenture or thereafter owing by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Kurze Angaben A.the real property other than scottish real property and the northern irish real property;B.all rights and claims to which llnhp and each partner is at the date of the debenture or may thereafter become entitled in relation to all monies at the date of the debenture or at any time standing to the credit of any bank accounts.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0