KUNICK INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKUNICK INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03429943
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thonton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLLCOVER LIMITED05. Sept. 199705. Sept. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom am 07. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 23. Nov. 2012

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2012

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 18,900,002
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Leisure Connection Ltd Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom am 05. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Low Lane Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4ER am 03. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    14 SeitenAA

    Ernennung von Mr Julian Frederick Nicholls als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Paul Meehan als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard Matthew Still als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Danoptra Director Ii Limited am 05. Sept. 2010

    2 SeitenCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Deed of assignment 19/08/2008
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KUNICK INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Uk
    EnglandBritish95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED
    Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low
    Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low
    Yorkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03429943
    125899730001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Geschäftsführer
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    British809230004
    STILL, Richard Matthew
    19 Fairway
    Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 Fairway
    Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    British71581460001
    DANOPTRA DIRECTOR I LIMITED
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    125899680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat KUNICK INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 22. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 21. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Hat KUNICK INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    29. Apr. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0