EVENTCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEVENTCO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03432133
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EVENTCO LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich EVENTCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Freemans Way
    Harrogate
    HG3 1DH North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVENTCO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EVENTCO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für EVENTCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 26. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 26. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ01

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von David Elson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Elson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von EVENTCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELSON, David William
    103 Otley Road
    HG2 0AG Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    103 Otley Road
    HG2 0AG Harrogate
    North Yorkshire
    British53229470002
    GREENWOOD, John Richard Heaton
    177 Marine Drive
    Rhos On Sea
    LL28 4LA Colwyn Bay
    Clwyd
    Sekretär
    177 Marine Drive
    Rhos On Sea
    LL28 4LA Colwyn Bay
    Clwyd
    BritishDirector88772080003
    KELD, Christine Bernadette
    28 Kingfisher Drive
    YO18 8TA Pickering
    North Yorkshire
    Sekretär
    28 Kingfisher Drive
    YO18 8TA Pickering
    North Yorkshire
    British54968460001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    DARROCH, James Bruce
    23 Hereford Drive
    Kings Park Village
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    23 Hereford Drive
    Kings Park Village
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    United KingdomBritishDirector76333270002
    ELSON, David William
    103 Otley Road
    HG2 0AG Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    103 Otley Road
    HG2 0AG Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director53229470002
    GREENWOOD, John Richard Heaton
    177 Marine Drive
    Rhos On Sea
    LL28 4LA Colwyn Bay
    Clwyd
    Geschäftsführer
    177 Marine Drive
    Rhos On Sea
    LL28 4LA Colwyn Bay
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector88772080003
    WELSH, James
    30 Highburgh Road
    G12 9DZ Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    30 Highburgh Road
    G12 9DZ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector110377700002
    WOOLASTON, Jason Rodney
    2 Glamis Way
    UB5 4SU Northolt
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Glamis Way
    UB5 4SU Northolt
    Middlesex
    BritishDirector123813960001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat EVENTCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 02/05/2006 and
    Erstellt am 05. Okt. 2007
    Geliefert am 13. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    30 freemans way harrogate. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 207. Okt. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 228. Sept. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 17. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 2006
    Geliefert am 15. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 09. März 2006
    Geliefert am 15. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 18 stray towers victoria road harrogate north yorkshire t/n nyk 256258. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 307. Okt. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 328. Sept. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as adam house ripon way harrogate. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Nov. 2000
    Geliefert am 01. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 stray towers victoria road harrogate north yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Mai 1999
    Geliefert am 13. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EVENTCO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. März 2014Abschluss der Liquidation
    26. Apr. 2010Antragsdatum
    15. Juni 2010Beginn der Liquidation
    07. Juni 2014Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    Praktiker
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Keith Roe
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Keith Roe
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0