ACCESS HOMECARE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ACCESS HOMECARE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03433621 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACCESS HOMECARE LIMITED?
- (8532) /
Wo befindet sich ACCESS HOMECARE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACCESS HOMECARE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ACCESS HOMECARE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angela Culhane als Geschäftsführer am 25. Juni 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Jonathan David Calow als Sekretär am 08. Dez. 2011 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Care Uk Services Ltd als Sekretär am 08. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Paul John Watson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Justin Humphreys am 01. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Care Uk Services Ltd am 01. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael Robert Parish am 10. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Deborah Jane Marriott-Boam als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Benn als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Douglas Umbers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Angela Hector Culhane als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roy Hastings als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von ACCESS HOMECARE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALOW, Jonathan David | Sekretär | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | 165428570001 | |||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Geschäftsführer | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Director | 33223550003 | ||||||||
MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Geschäftsführer | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Company Director | 151689670001 | ||||||||
PARISH, Michael Robert | Geschäftsführer | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | Director | 78828750003 | ||||||||
WATSON, Paul John | Geschäftsführer | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | Accountant | 82460360003 | ||||||||
HORROCKS, Stephen Kevin | Sekretär | Farnborough Road BL1 7HJ Bolton 25 Lancashire United Kingdom | British | 128758490001 | ||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Sekretär | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | Director | 33223550003 | |||||||||
CARE UK SERVICES LTD | Sekretär | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
BENN, Geoffrey Richard | Geschäftsführer | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | Company Director | 73786580001 | ||||||||
BOOKER, Roger Ian | Geschäftsführer | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | Director | 14044530003 | ||||||||
CULHANE, Angela | Geschäftsführer | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | Company Director | 68602910001 | ||||||||
HASTINGS, Roy | Geschäftsführer | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | England | British | Company Director | 130098430001 | ||||||||
QUINN, David Laurence, Mr. | Geschäftsführer | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | Company Director | 123356660001 | ||||||||
TRAYNOR, Shirlie Rose | Geschäftsführer | 19 Burnedge Lane Grasscroft OL4 4EA Oldham | United Kingdom | British | Managing Director | 54634440002 | ||||||||
UMBERS, Douglas | Geschäftsführer | Tyrrel House Tyrrel Road Chandlers Ford SO53 1GG Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 90541690001 | ||||||||
VOCKINS, Anthony Frederick | Geschäftsführer | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | Company Director | 130512090002 |
Hat ACCESS HOMECARE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 21. Juli 2010 Geliefert am 26. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Dez. 2009 Geliefert am 23. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. März 2007 Geliefert am 04. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Mai 2002 Geliefert am 18. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 97-111 turner lane ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Jan. 2002 Geliefert am 26. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0