WAVENEY SHIPPING II PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWAVENEY SHIPPING II PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03435076
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WAVENEY SHIPPING II PLC?

    • (6110) /

    Wo befindet sich WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Begbies Traynor (South) Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STATEACE PLC17. Sept. 199717. Sept. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Mai 2014

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2009

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Peter Rostron als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Jan. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2008

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von WAVENEY SHIPPING II PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROSTRON, Peter James
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    British10092480004
    COBB, David Bilsland
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    British73830490002
    ROYDS, David John George
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    Geschäftsführer
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    EnglandBritish141447410001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    DOUGLAS, John Campbell
    Kingswear House
    Church Hill, Kingswear
    TQ6 0BX Dartmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Kingswear House
    Church Hill, Kingswear
    TQ6 0BX Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritish1822320003
    LISTER, Charles Lees
    Haggle House
    Scole Road, Thorpe Abbotts
    IP21 4HS Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Haggle House
    Scole Road, Thorpe Abbotts
    IP21 4HS Diss
    Norfolk
    British36741080009
    ROSTRON, Peter James
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish10092480004
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    Hat WAVENEY SHIPPING II PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of accession
    Erstellt am 09. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    An aggregate principal amount not exceeding £18,750,000 and all other monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the insurances the earnings the charter rights and the requisition compensation in relation to the vessel M.V. "waveney citadel". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester Commercial Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A second priority british ship mortgage
    Erstellt am 09. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    32/64THS shares in the vessel being M.V. "waveney citadel" and includes any interest therein and her engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or otherstores belongong and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester Commercial Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignment of the insurances, the earnings, the charter rights and the requisition compensation in respect of the M.V. waveney fortress
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the owner's right title and interest in and to the assigned property being the insurances the earnings the charter rights and the requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A first priority british ship mortgage in respect of M.V. waveney fortress
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The motor vessel "waveney fortress". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenants
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Motor vessel waveney fortress registred in the ownership of the company under the flag of the united kingdom of great britain and northern ireland at the port of london with official number 902141 together with all her engines machinery boats tackle outfit fuels spares consumable and other stores belongings and appurtenances on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account security
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, liabilities and obligations due or to become due from waveney shipping PLC ("waveney I") and waveney shipping ii PLC ("waveney ii") (the "borrowers") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The account balances and all rights,titles and interests of the borrowers in and to the accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. Mai 2000
    Geliefert am 15. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement dated 7TH april 1998 and/or any of the other agreements as defined
    Kurze Angaben
    And any patent,copyright,registered design,trade mark; the benefit of any licence. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 02. Mai 2000
    Geliefert am 15. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement dated 7TH april 1998 and/or any of the other agreements as defined
    Kurze Angaben
    All right,title and interest whatsoever in all amounts from time to time credited or standing to the credited of various account numbers as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 06. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 7 april 1998 pursuant to which the bank has agreed to make available to the company,inter alia,a loan and an overdraft facility,the overdraft facility being up to £500,000 as the same may be amended and/or supplemented from time to time (the "facility agreement") and the security documents (as defined in the facility agreement)
    Kurze Angaben
    All amounts from time to time and at any time credited to,or standing to the credit of the account number 0727542 designated "waveney shipping ii PLC-earnings account" opened with the bank at bank house,wine street,bristol BS1 2AN in the name of the company pursuant to clause 11 of the facility agreement into which the earnings are to be paid.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenants
    Erstellt am 06. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 7 april 1998 pursuant to which the bank has agreed,inter alia,to make available to the company a loan and an overdraft facility,the overdraft facility being up to £500,000 and the security documents (as defined in the deed of covenants)
    Kurze Angaben
    The M.V."waveney fortress" (the "ship") registered as a UK ship with official number 902141 and including any share or interest therein and the hull,machinery,equipment,fuel and stores thereof whether now owned or hereafter acquired and all additions,improvements and replacements hereafter made in or to the ship or any part thereof and/or the said equipment;all freight,hire and any other amounts whatsoever which may be earned to or for the account of the company or their agents.all policies and contracts of insurance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First statutory mortgage
    Erstellt am 06. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under a facility agreement dated 7 april 1998 as from time to time amended or supplemented and a deed of covenants dated 6 july 1999 as from time to time amended or supplemented
    Kurze Angaben
    64/64TH shares of the M.V."waveney fortress" registered in the name of the company under UK flag with official number 902141 and its appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment agreement
    Erstellt am 07. Apr. 1998
    Geliefert am 17. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 7TH april 1998 and the security documents (as defined in the assignment agreement)
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and under (a) the shipbuilding contract dated 12/1/89, (b) the insurances on hull no.15 (The "ship") and (c) the refund guarantee dated 3RD april 1998.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WAVENEY SHIPPING II PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Jan. 2007Beginn der Liquidation
    14. Aug. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Paul Hudson
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Vivian Murray Bairstow
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0