RELAND (WEEDON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRELAND (WEEDON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03435816
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RELAND (WEEDON) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAVALRY CENTRE LIMITED20. Nov. 199720. Nov. 1997
    HUNTERMILE LIMITED18. Sept. 199718. Sept. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Ross Brodie als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 32
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 32
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Catchpole als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147811200001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    British35117250001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Sekretär
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Geschäftsführer
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    Hat RELAND (WEEDON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A bond and floating charge
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2009
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Juli 2000
    Geliefert am 27. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 1997
    Geliefert am 03. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Nov. 1997
    Geliefert am 03. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0