RELAND (WEEDON) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RELAND (WEEDON) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03435816 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RELAND (WEEDON) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CAVALRY CENTRE LIMITED | 20. Nov. 1997 | 20. Nov. 1997 |
| HUNTERMILE LIMITED | 18. Sept. 1997 | 18. Sept. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Ross Brodie als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Catchpole als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RELAND (WEEDON) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147811200001 | |||||||
| SHARP, Giles Henry | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| DIPRE, Remo | Sekretär | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | British | 35117250001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Sekretär | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| TAYLOR, David John | Sekretär | Green Lane TN6 3DG Crowborough Valleyoak East Sussex | British | 136521790001 | ||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | 62279790001 | |||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | 62279790001 | |||||
| BURNLEY, John Lewis | Geschäftsführer | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CURRAN, Paul | Geschäftsführer | Syme Place EH10 5GA Edinburgh 13 Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 110978610002 | |||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Geschäftsführer | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOYLE, Betty June | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||
| MILLIGAN, Michael | Geschäftsführer | 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh Quartermile Two Scotland Scotland | Scotland | British | 153845120001 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 207729000002 |
Hat RELAND (WEEDON) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A bond and floating charge | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juli 2000 Geliefert am 27. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Nov. 1997 Geliefert am 03. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Nov. 1997 Geliefert am 03. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0