P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03435827 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED?
- (4521) /
Wo befindet sich P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Old Exchange 234 Southchurch Road SS1 2EG Southend On Sea Essex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 15 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2015 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2014 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2013 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 12 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 70 Whalebone Lane South Dagenham Essex RM8 1BB* am 02. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 01. Nov. 2011
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Konten erstellt bis 31. März 2010 | 6 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Roy Smith am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Stephen Roy | Geschäftsführer | Marles Farm Cottage CM16 6PF Epping Essex | England | British | Surveyor | 104810770001 | ||||
GILL, Duncan Edward | Sekretär | Lower Farm Road Maldon Road, Hatfield Peverel CM3 2JP Chelmsford | English | Contractor | 42028800003 | |||||
M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HP London | 900007890001 | |||||||
STREATHAM SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Foresters Hall 25-27 Westow Street SE19 3RY Upper Norwood London | 108080670001 | |||||||
GILL, Duncan Edward | Geschäftsführer | Lower Farm Road Maldon Road, Hatfield Peverel CM3 2JP Chelmsford | England | English | Contractor | 42028800003 | ||||
O'NEILL, Stephen Christopher | Geschäftsführer | Briar Cottage 11 Upper Woodcote Village CR8 3HE Purley Surrey | England | British | Chartered Accountant | 141541670001 | ||||
WICKERS, David William | Geschäftsführer | 90 Avon Road RM14 1RF Cranham Essex | United Kingdom | British | Building Surveyor | 87337810001 | ||||
DOUGLAS NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HF London | 900007880001 |
Hat P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 19. Aug. 2003 Geliefert am 29. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 7 church heights hythe kent title number K830443. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Feb. 2003 Geliefert am 22. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Sept. 2001 Geliefert am 19. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £220,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement or otherwise | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a PLOT7 the nursery site hythe kent forming part of the land k/a 19 church hill land on the south side of north road and land on the north side of hillside street hythe kent carline court northampton t/n K392392. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Sept. 2001 Geliefert am 19. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £220,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement or otherwise | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a plot 7 the nursery site hythe kent forming part of the land k/a 19 church hill land on the south side of north road and land on the north side of hillside street hythe kent carline court northampton t/n K392392. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat P.B.M. BUILDING SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0