DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03444409 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 13. Juli 2021
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neeraj Kapur als Direktor am 01. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon George Thomas als Geschäftsführer am 31. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Charles Fisher als Geschäftsführer am 03. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Simon George Thomas als Direktor am 03. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David George Whincup als Sekretär am 16. Juli 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paula Watts als Sekretär am 31. März 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHINCUP, David George | Sekretär | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 249464050001 | |||||||
| KAPUR, Neeraj | Geschäftsführer | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford Provident Financial Plc West Yorkshire United Kingdom | England | British | 268623050001 | |||||
| LE MAY, Malcolm John | Geschäftsführer | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 43422720003 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Sekretär | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Sekretär | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Sekretär | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| VERSLUYS, Emma Gayle | Sekretär | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | British | 102724740003 | ||||||
| WATTS, Paula | Sekretär | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 232277070001 | |||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| COOPER, Julian Edward Peregrine | Geschäftsführer | 17b Sheridan Road Merton Park SW19 3HW London | United Kingdom | British | 91049680001 | |||||
| CROOK, Peter Stuart | Geschäftsführer | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 109187730001 | |||||
| DUNKLEY, Paul John | Geschäftsführer | Stoke Gap House Ashton Road Stoke Bruerne NN12 7SL Towcester Northamptonshire | England | British | 34398930002 | |||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Geschäftsführer | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Geschäftsführer | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FISHER, Andrew Charles | Geschäftsführer | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 41331580002 | |||||
| GLEN, Robert John | Geschäftsführer | 5 High Meadows Firth Lane Wilsden BD15 0HN Bradford West Yorkshire | England | United Kingdom | 87214920001 | |||||
| HARRISON, Richard | Geschäftsführer | 97 Orchard Grove Chalfont St Peter SL9 9ET Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 100892740002 | ||||||
| JOHNSTONE, Christopher Charles | Geschäftsführer | Pine Lodge Castle Lane Ripponden HX6 4JZ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 53747580002 | ||||||
| LINDSEY, Ian Walter | Geschäftsführer | 3 Kinderscout HP3 8HW Leverstock Green Hertfordshire | United Kingdom | British | 85980860001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Geschäftsführer | Murrayfield 13 Windsor Road SL9 7NB Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Geschäftsführer | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Geschäftsführer | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| NEWBY, Anthony Charles | Geschäftsführer | Millhouse Church Road, Woolton L25 6DA Liverpool | British | 54172180002 | ||||||
| NEWBY, Anthony | Geschäftsführer | 51 Wheatcroft Road Allerton L18 9UF Liverpool | British | 54172180001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Geschäftsführer | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| PARSONAGE, Robert David | Geschäftsführer | Homeleigh 10 Chart Way RH2 0NZ Reigate Surrey | British | 108363060001 | ||||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Geschäftsführer | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Geschäftsführer | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PRINCE, Joseph Michael | Geschäftsführer | Keffolds 44 Tongdean Avenue BN3 6TN Hove East Sussex | British | 71867540003 | ||||||
| PRINCE, Joseph Michael | Geschäftsführer | Meadowside Piltdown TN22 3XD Uckfield East Sussex | British | 71867540001 | ||||||
| SHAW, Simon Andrew | Geschäftsführer | Horrocks Close BD20 8HQ Lothersdale North Yorkshire | Uk | British | 87062650001 | |||||
| THOMAS, Simon George | Geschäftsführer | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | England | British | 253188120001 | |||||
| THORNTON, John Rolfe | Geschäftsführer | Kirk Lea Main Street HG5 9LD Staveley North Yorkshire | United Kingdom | British | 147555560001 | |||||
| WEBSTER, James Maxwell | Geschäftsführer | 28d Cruden Street N1 8NH London | United Kingdom | British | 97036540001 | |||||
| YATES, Stuart William | Geschäftsführer | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | 108370390001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Financial Plc | 06. Apr. 2016 | Godwin Street BD1 2SU Bradford No 1 Godwin Street England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed of charge | Erstellt am 12. Juni 2002 Geliefert am 19. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit of the company in and to the scottish funded receivables. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of charge | Erstellt am 09. März 2001 Geliefert am 28. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined) | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit in and to the scottish funded receivables to the extent not previously assigned in favour of the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Scottish trust security | Erstellt am 08. März 2001 Geliefert am 28. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the debenture, the facility agreement, the transaction documents and such other documents (if any) as may constitute or evidence any of the secured obligations. | |
Kurze Angaben The funded receivables governed by scots law forming part of the funded receivables and all amounts becoming payable thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. März 2001 Geliefert am 28. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental deed to composite guarantee and debenture dated 26 july 1999 | Erstellt am 08. März 2001 Geliefert am 27. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 26 july 1999, a composite guarantee and debenture dated 26 july 1999, a facility agreement dated 26 july 1999, an inter-creditor agreement dated 26 july 1999, a subordination deed 26 july 1999 and the first supplemental deed and any and all other mortgages, charges, guarantees and other instruments from time to time entered into by the parent and/or both/either of the borrowers by way of guarantee or other assurance of and/or security for amounts owed to the bank under the facility agreement | |
Kurze Angaben The debenture charges all the present and future assets of the company. First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types (a) land, interests in land and fixtures (b) plant, machinery and equipment (c) shares, bonds and other securities of any kind (d) debts and claims (e) the proceeds of collection of debts and claims and credit balances at banks (f) the benefit of insurances (g) goodwill and uncalled capital (h) intellectual property of all kinds in each case, together with all associated rights (the fixed charge). Excluded from the fixed charge are all of the undertakings, assets, interests, rights and benefits of the company which are charged by way of fixed charge in favour of spartacus one, incorporated pursuant to a debenture dated 8 march 2001. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. Juli 1999 Geliefert am 30. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee on behalf of itself and the banks from time to time parties to the facility agreement under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 16. Dez. 1997 Geliefert am 30. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company | |
Kurze Angaben K/A unit 2 monckton road industrial estate denby dale road, wakefield t/no: WYK592491 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0