LISA ESTATES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LISA ESTATES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03445892 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LISA ESTATES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich LISA ESTATES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Church Lane Wallingford OX10 0DX Oxfordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LISA ESTATES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2015 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LISA ESTATES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LISA ESTATES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Mr Brian Patrick Mills als Direktor am 01. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034458920007, erstellt am 16. März 2016 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Angela South als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Richard Thompson am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 10 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LISA ESTATES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILLS, Brian Patrick | Geschäftsführer | 1 Church Lane Wallingford OX10 0DX Oxfordshire | England | English | Director | 27298790004 | ||||
SOUTH, Angela | Geschäftsführer | 1 Church Lane Wallingford OX10 0DX Oxfordshire | United Kingdom | British | Sales & Marketing Director | 89523210003 | ||||
THOMPSON, Christopher Richard | Geschäftsführer | 1 Church Lane Wallingford OX10 0DX Oxfordshire | United Kingdom | British | Surveyor | 65604290006 | ||||
BARTON, Julie Hilda | Sekretär | Glade House Pishill RG9 6HJ Henley On Thames Oxfordshire | British | 55309160001 | ||||||
CEZAIR, Gregory Sean | Sekretär | 3 Millington Road OX10 8FE Wallingford Oxfordshire | British | 104208690001 | ||||||
LEWIN, Malcolm Thomas | Sekretär | 10 Lonsdale Road OX2 7EW Oxford Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 30299540003 | |||||
SOUTH, Angela | Sekretär | 1 The Hydons Salt Lane GU8 4DD Godalming Surrey | British | 89523210001 | ||||||
STANLEY, Karen Elizabeth | Sekretär | Ashampstead Road RG8 8NS Upper Basildon Fairmead Berkshire | British | Chartered Accountant | 140765820001 | |||||
STANLEY, Karen Elizabeth | Sekretär | Ashampstead Road RG8 8NS Upper Basildon Fairmead Berkshire | British | Chartered Accountant | 140765820001 | |||||
WAPLE, Simon Timothy | Sekretär | 61a Albany Road Statham WA13 9LT Lymm Cheshire | British | 86968910001 | ||||||
JPCORS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001430001 | |||||||
BARTON, Michael Anthony | Geschäftsführer | Glade House Pishill Bottom RG9 6HJ Henley On Thames Oxon | United Kingdom | British | Director | 114503620001 | ||||
LEWIN, Malcolm Thomas | Geschäftsführer | 10 Lonsdale Road OX2 7EW Oxford Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 30299540003 | |||||
MOSSOP, Guy Siddle Christie | Geschäftsführer | Grove Cottage Lower Inkpen RG17 9DG Hungerford | England | British | Director | 5549070001 | ||||
STANLEY, Karen Elizabeth | Geschäftsführer | Ashampstead Road RG8 8NS Upper Basildon Fairmead Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 140765820001 | ||||
THORNTON, Henry John Dudley | Geschäftsführer | Hillgreen Farmhouse Church Road Cholsey OX10 9PR Wallingford Oxfordshire | England | British | Director | 91062610001 | ||||
JPCORD LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001420001 |
Hat LISA ESTATES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 16. März 2016 Geliefert am 30. März 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A charge of certified shares and securities | Erstellt am 13. März 2013 Geliefert am 21. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The securities, - the unlisted shaers as 1 ordinary share of £1.00 in lisa estates (delancey) limited and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Mai 2003 Geliefert am 21. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (the principal borrower) to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and fixed and floating security document (the "security document") | Erstellt am 22. Okt. 2001 Geliefert am 08. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities whatsoever due or to become due from the company to any beneficiary (as defined) under the guarantee and the group financing documents (as defined) and the security document | |
Kurze Angaben Including (I) millmarsh lane,enfield EN3 7AG; ngl 5924; (ii) sowton 30,sidmouth rd,exeter; dn 407452; (iii old railway works,newton rd,ashford (all freehold ) plus other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at little london lechlade gloucester.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 425,000 due from the company to the chargee under the terms of this legal charge | |
Kurze Angaben Hall court little london lechlade gloucester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 29. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0