BRENTANO PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRENTANO PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03447707
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Eighth Floor
    6 New Street Square
    London
    Ec4a 3aq
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    IT'S A BIG BAG WORLD LIMITED10. Okt. 199710. Okt. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Lower Mill Kingston Road Epsom Surrey KT17 2AE United Kingdom zum Q3 the Square Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TW geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Lower Mill Kingston Road Epsom Surrey KT17 2AE verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2014

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    4 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2012

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Jonathan Phillip Kraines als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gurpreet Sarang als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Direktors für Stephen Barry Spitz am 09. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Gurpreet Singh Sarang am 09. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von BRENTANO PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KRAINES, Jonathan Phillip
    Eighth Floor
    6 New Street Square
    London
    Ec4a 3aq
    Sekretär
    Eighth Floor
    6 New Street Square
    London
    Ec4a 3aq
    British153891050001
    SPITZ, Stephen Barry
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Geschäftsführer
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    EnglandBritishDirector8729070003
    CURWEN, Philip James
    7 Norman Close
    KT18 5RU Epsom
    Surrey
    Sekretär
    7 Norman Close
    KT18 5RU Epsom
    Surrey
    BritishChartered Accountant81293290001
    KRAINES, Jonathan Phillip
    37 Silverston Way
    HA7 4HS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    37 Silverston Way
    HA7 4HS Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector29202080003
    SARAKINSKY, Atholl
    45c Lancaster Grove
    Belsize Park
    NW3 4HB London
    Sekretär
    45c Lancaster Grove
    Belsize Park
    NW3 4HB London
    South African83028330001
    SARANG, Gurpreet Singh
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Sekretär
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    British100639450002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    KRAINES, Jonathan Phillip
    37 Silverston Way
    HA7 4HS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    37 Silverston Way
    HA7 4HS Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector29202080003
    MCGUINNESS, Peter
    Spindles Duck Street
    Little Easton
    CM6 2JF Great Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    Spindles Duck Street
    Little Easton
    CM6 2JF Great Dunmow
    Essex
    EnglandBritishDirector8822600003
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat BRENTANO PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 2007
    Geliefert am 04. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £150,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Flat 2 abbey house, abbey road london.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 leigh house, 73 south end road hampstead greater london - l/b of camden t/no: NGL353032. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 2, 133 commercial street greater london - tower hamlets t/no: EGL375711. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 2, abbey house, 1A abbey road greater manchester-city of westminster t/no: NGL734330. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10A westbourne terrace road warwick estate greater london - city of westminster t/no: NGL616261. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 ascot court grove end road greater london - city of westminster t/no: NGL457768. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 33, gilbey house, 38 to 46 (even) jamestown road and parking space 54 greater london l/b of camden t/no: NGL748224. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juli 2001
    Geliefert am 19. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 2000
    Geliefert am 13. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 33 gilbey house 38 jamestown road london - NGL748224.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Apr. 2000
    Geliefert am 27. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £225,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Flat 2 abbey house abbey road st. John's wood london NW8.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 2000
    Geliefert am 24. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H flat 4 leigh house south end road hampstead london t/n-NGL353032.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1999
    Geliefert am 04. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 10A westbourne terrace london W2.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Sept. 1999
    Geliefert am 08. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 ascot court melina place st johns wood l/b of city of westminster t/n NGL457768.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 1998
    Geliefert am 07. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge by the company and ploystep limited as mortgagor and by the company as trustee for the mortgagor and as principal debtor
    Erstellt am 17. Juni 1998
    Geliefert am 08. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or ploystep limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 2, 133 commercial street l/b of tower hamlets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0