3447841 PLC
Überblick
| Unternehmensname | 3447841 PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 03447841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 3447841 PLC?
- (5530) /
Wo befindet sich 3447841 PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 3447841 PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HARTFORD GROUP PLC | 12. Feb. 1998 | 12. Feb. 1998 |
| TECHTEAM LIMITED | 10. Okt. 1997 | 10. Okt. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 3447841 PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Sept. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 3447841 PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Feb. 2010 | 6 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 03. Feb. 2010 | 6 Seiten | 2.35B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 2 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Aug. 2009 | 10 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 2 Seiten | 2.31B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Feb. 2009 | 7 Seiten | 2.24B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 3 Seiten | 2.23B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 50 Seiten | 2.16B | ||
Vorschlag des Verwalters | 155 Seiten | 2.17B | ||
Vorschlag des Verwalters | 11 Seiten | 2.17B | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 29. Sept. 2007 | 39 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 3447841 PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Stephen Rushworth | Sekretär | White Cottage 33 Heathfield SG8 5BN Royston Hertfordshire | British | 6894950002 | ||||||
| KOWSZUN, James Stephen Peregrine | Geschäftsführer | Bancroft Mill Road RH22 PZ West Chittington West Sussex | United Kingdom | British | 150123500001 | |||||
| MCCLYMONT, Raymond Alexander | Geschäftsführer | 12 Turnpike Close LE16 7TJ Market Harborough Leicestershire | Market Harborough | British | 115919060001 | |||||
| SMITH, Stephen Rushworth | Geschäftsführer | White Cottage 33 Heathfield SG8 5BN Royston Hertfordshire | United Kingdom | British | 6894950002 | |||||
| THOMAS, Stephen Charles | Geschäftsführer | Newnham Hall Poets Way, Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 66198390004 | ||||||
| WILLIAMS, John Raymond | Geschäftsführer | Broom House Long Reach KT24 6NE West Horsley Surrey | British | 126563940001 | ||||||
| EDELSON, Jacqueline Barbara | Sekretär | 17 Carrwood Hale Barns WA15 0ED Altrincham Cheshire | British | 33622500001 | ||||||
| MARSHALL, Nicholas Geoffrey | Sekretär | 14 Somersby Drive Bromley Cross BL7 9PX Bolton Lancashire | British | 50778540001 | ||||||
| PAREKH, Urvashi Dipak | Sekretär | 254 Harrow Road HA9 6QL Wembley Middlesex | British | 80159940001 | ||||||
| SALINGER, Michael Lawton | Sekretär | 39 Broadfields Avenue HA8 8PF Edgware Middlesex | British | 22146140001 | ||||||
| WING, Clifford Donald | Sekretär | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | 38279030001 | ||||||
| CONNOLLY, Michael Joseph | Geschäftsführer | Tower House Woodlands Grove Grimsargh PR2 5LB Preston Lancashire | British | 3275550001 | ||||||
| EDELSON, Jacqueline Barbara | Geschäftsführer | 17 Carrwood Hale Barns WA15 0ED Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 33622500001 | |||||
| EDELSON, John Michael | Geschäftsführer | 17 Carrwood WA15 0ED Hale Barns Cheshire | England | British | 28353840001 | |||||
| FINCH, Kevin Michael | Geschäftsführer | The Barn Rue Jacques, St. Sampson GY2 4NJ Guernsey Channel Islands | United Kingdom | British | 39840540005 | |||||
| FREUD, Matthew Rupert | Geschäftsführer | China Corner Blenheim Park OX20 1PR Woodstock Oxfordshire | England | British | 64960840001 | |||||
| GARDNER, Douglas Charles | Geschäftsführer | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| KENNEDY, Simon Jonathan | Geschäftsführer | 69a Oxford Gardens W10 5UJ London | British | 49954590001 | ||||||
| LESLAU, Nicholas Mark | Geschäftsführer | Romneys House 5 Holly Bush Hill Hampstead Village NW3 6SH London | British | 6815470006 | ||||||
| LEWIN, Colin | Geschäftsführer | 3 Davis Close SL7 1SY Marlow Buckinghamshire | England | British | 72088090002 | |||||
| LYONS, Jonathan Howard | Gesch äftsführer | The Gables Rossmill Lane WA15 0AH Altrincham Cheshire | England | British | 12396450001 | |||||
| LYONS, Judy Estelle | Geschäftsführer | Treetops Castleway Hale Barns WA15 0AD Altrincham Cheshire | British | 30741450001 | ||||||
| MCKENZIE, Sheila | Geschäftsführer | 81 Oxford Road South W4 3DD London | British | 108540600001 | ||||||
| PAREKH, Urvashi Dipak | Geschäftsführer | 254 Harrow Road HA9 6QL Wembley Middlesex | United Kingdom | British | 80159940001 | |||||
| PICKARD, Rooney David | Geschäftsführer | 4 Anson Close AL4 9EN Sandridge Hertfordshire | British | 90772730001 | ||||||
| POIL, Christopher David | Geschäftsführer | Blackheath GU4 8QS Guildford Tangley Way Surrey | England | Uk | 138552310001 | |||||
| SCOTT, Simon Edward | Geschäftsführer | 21 Willow Road NW3 1TL London | British | 59814780001 | ||||||
| SHAH, Kamal Somchand | Geschäftsführer | 12 Hazel Gardens HA8 8PE Edgware Middlesex | England | British | 9765160001 | |||||
| SPENCER, Jeremy Paul | Geschäftsführer | 5 Hawthorn Road WR11 1HP Evesham Worcestershire | British | 80160250001 | ||||||
| WRAY, Nigel William | Geschäftsführer | The Priory 54 Totteridge Village N20 8PS London | United Kingdom | British | 45400750007 | |||||
| BONUSWORTH LIMITED | Geschäftsführer | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 39406570001 |
Hat 3447841 PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over intellectual property rights | Erstellt am 16. Mai 2008 Geliefert am 22. Mai 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The intellectual property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 2007 Geliefert am 23. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H willys wine bar basement and part ground floor 107 fenchurch street london t/n NGL666943. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 2007 Geliefert am 23. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H basement ground floor and mezzanine room of 115/115A chancery lane t/n NGL52041. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 2007 Geliefert am 23. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H ground floor and lower ground floor of part 10-18 (even) london bridge street london t/n TGL149495. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 13. März 2007 Geliefert am 22. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re the food & drink group PLC business premium account account number 70327107. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2005 Geliefert am 11. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 10. März 2005 Geliefert am 22. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Juli 2004 Geliefert am 31. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £37,500.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. Nov. 2000 Geliefert am 04. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £18,750 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £18,750 held pursuant to a rent deposit deed of even date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Dilapidations deposit deed | Erstellt am 20. Nov. 2000 Geliefert am 04. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £15,000 held pursuant to a dilapidations deposit agreement of even date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 22. Juni 2000 Geliefert am 30. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1998 Geliefert am 07. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 25. Feb. 1998 Geliefert am 07. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies from time to time held to the credit of the company by the bank on any current deposit or other account or accounts under any deposit receipt. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat 3447841 PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0