EDGWARE 174
Überblick
| Unternehmensname | EDGWARE 174 |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 03452071 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EDGWARE 174?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich EDGWARE 174?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ascential Group Limited The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EDGWARE 174?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WORTH GLOBAL STYLE NETWORK LIMITED | 16. Apr. 1998 | 16. Apr. 1998 |
| STYLE NETWORK LIMITED | 20. Okt. 1997 | 20. Okt. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDGWARE 174?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EDGWARE 174?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Louise Meads als Sekretär am 06. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP zum C/O Ascential Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP am 14. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susanna Freeman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Amanda Jane Gradden als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Gulliver als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Greater London House Hampstead Road London NW1 7EJ United Kingdom* am 01. Nov. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Susanna Freeman als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Gestetner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von John Keith Gulliver als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EDGWARE 174?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOI, Shanny | Sekretär | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
| MEADS, Louise | Sekretär | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | 224385780001 | |||||||
| GRADDEN, Amanda Jane | Geschäftsführer | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | England | British | 77425910003 | |||||
| PAINTER, Duncan Anthony | Geschäftsführer | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | England | British | 132649960001 | |||||
| ELSDON, Kate | Sekretär | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| FREEMAN, Susanna | Sekretär | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | 173152770001 | |||||||
| HAY, Helen Frances | Sekretär | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146423790001 | |||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Sekretär | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Sekretär | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| WORTH, Julian Otto | Sekretär | Willowbrook Old Melton Road Normanton On The Wol Keyworth NG12 5NH Nottingham | British | 49877690001 | ||||||
| WYNNE THOMAS, Giles Owen | Sekretär | 34 Woodside Road TN13 3HF Sevenoaks Kent | British | 69374400003 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| AYDINOGLU, Bozkurt | Geschäftsführer | Top Floor 16 Tanza Road NW3 2UB London | British | 98940450002 | ||||||
| BAHNS, Robert Harold | Geschäftsführer | 40a Parkhill Road NW3 2YP London | British | 64794090001 | ||||||
| BROWN, Philip | Geschäftsführer | Greydene Station Road, Woldingham CR3 7DD Caterham Surrey | United Kingdom | British | 70412460002 | |||||
| CARTER, Derek Raymond Anthony | Geschäftsführer | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 29959930002 | |||||
| ELLIOT, Richard Emmerson | Geschäftsführer | Orchard House 2 Richardson Close, Mill Drove PE10 9YN Bourne Lincolnshire | United Kingdom | British | 40591070005 | |||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Geschäftsführer | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Geschäftsführer | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| GIROUD, Bernard Philippe | Geschäftsführer | 23 Avenue Emile Deschanel FOREIGN Paris 75007 France | French | 74580230001 | ||||||
| GRAY, Tracey Marie | Geschäftsführer | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 130960400002 | |||||
| GRIFFITHS, Ian Ward | Geschäftsführer | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | 99547790001 | |||||
| GULLIVER, John Keith | Geschäftsführer | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | United Kingdom | British | 170112360001 | |||||
| HEALEY, Andrew Mark | Geschäftsführer | 37 Lawn Crescent Kew TW9 3NS Richmond Surrey | United Kingdom | British | 77351950001 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Geschäftsführer | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 134332760002 | |||||
| LITTLEBOY, Ronald Frederick | Geschäftsführer | 71 Barnes High Street SW13 9LD London | British | 71490330001 | ||||||
| MILLARD, Nik | Geschäftsführer | Beech End Woodlands Glade HP9 1JZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 64322000001 | ||||||
| OSTIN, Olav | Geschäftsführer | Mill Farm Beeston Lane, Great Fransham NR19 2JF Dereham Norfolk | French | 78752230001 | ||||||
| RONCHI, Giorgio | Geschäftsführer | Via Serenella 3 Castagnola Switzerland | Italian | 74037670001 | ||||||
| SMITH, Michael | Geschäftsführer | 1st Floor 28 Savile Row W1S 2EU London | American | 76912430003 | ||||||
| THOMAS, Henry Carlton | Geschäftsführer | 140 Cottimore Lane KT12 2BN Walton On Thames Surrey | British | 114612950001 | ||||||
| TISON, Francois | Geschäftsführer | 53 Rue Orfila FOREIGN Paris 75020 France | French | 69880760001 | ||||||
| WORTH, Julian Otto | Geschäftsführer | Pre Des Moines Sous Les Vignes 2 Dully 1195 Switzerland | British | 49877690008 | ||||||
| WORTH, Marcus Daniel | Geschäftsführer | 6 Linnell Drive NW11 7LJ London | British | 17045840006 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EDGWARE 174?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wgsn Limited | 06. Apr. 2016 | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EDGWARE 174 Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgages of assurance policies | Erstellt am 13. Nov. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy dated 26 march 1999 over the life of julian otto worth assuring the sum of £650,000WITH policy no: 9A6871V together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgages of assurance policies | Erstellt am 13. Nov. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy dated 26 march 1999 over the life of marcus daniel worth assuring the sum of £650,000 with policy no: 9A6877H together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Nov. 2003 Geliefert am 19. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1999 Geliefert am 11. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit dated 19/5/98 between the company and heat seal (textiles) limited | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 09. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations of the company,formerly known as style network limited,("the tenant") to the chargee under a lease dated 22ND may 1998 and all other obligations due under this deed | |
Kurze Angaben Sum of £21,500 plus vat and any other sums from time to time deposited by the tenant in a separate designated deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 1998 Geliefert am 28. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0