GATEWAY OFFSITE LTD
Überblick
| Unternehmensname | GATEWAY OFFSITE LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03453040 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GATEWAY OFFSITE LTD?
- (7499) /
Wo befindet sich GATEWAY OFFSITE LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unicorn House Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GATEWAY OFFSITE LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRITSPACE HOTELS LIMITED | 09. Dez. 2008 | 09. Dez. 2008 |
| GATEWAY FABRICATIONS LIMITED | 29. Dez. 1997 | 29. Dez. 1997 |
| TALKTOP LIMITED | 21. Okt. 1997 | 21. Okt. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GATEWAY OFFSITE LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GATEWAY OFFSITE LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Cowan als Sekretär am 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Sherriff als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Cowan als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom am 28. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS am 27. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Bradney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Harris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Terence Jackson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von James Bradney als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher John Huckle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Sherriff als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Clarke als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GATEWAY OFFSITE LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, David Christopher | Geschäftsführer | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 76088090001 | |||||
| HUCKLE, Christopher John | Geschäftsführer | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141831160001 | |||||
| BALL, Martin John | Sekretär | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | British | 63261140001 | ||||||
| CLARKE, Stephen | Sekretär | Unicorn House Broad Lane HU15 2TS Gilberdyke Brough East Yorkshire | British | 122285190001 | ||||||
| COWAN, Matthew | Sekretär | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | 161230490001 | |||||||
| FARMERY, Michael David | Sekretär | 26 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley East Yorkshire | British | 19792670001 | ||||||
| HORNCASTLE, Carole Diane | Sekretär | Beech Hill House Beech Hill Road, Swanland HU14 3QY North Ferriby East Yorkshire | British | 79178970001 | ||||||
| MCCANN, Leah | Sekretär | Flat 2 Merchants Warehouse Robinson Row HU1 2QX Hull East Yorkshire | British | 51908280001 | ||||||
| NEWTON, Christopher John Landsborough | Sekretär | The Old Brewery Main Street YO61 2NS Helperby North Yorkshire | British | 101779200001 | ||||||
| SHERRIFF, Ian | Sekretär | High Street Barmby-On-The-Marsh DN14 7HS Goole Grey Dene North Humberside United Kingdom | 149407420001 | |||||||
| WHITE, Norman | Sekretär | 19 Burnby Lane Pocklington YO42 2QB York North Yorkshire | British | 29472760001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ATKINSON, Stewart Martin | Geschäftsführer | Springwell 32 Bondend Road Upton St Leonards GL4 8DY Gloucester Gloucestershire | England | British | 100469640001 | |||||
| BALL, Martin John | Geschäftsführer | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BALL, Martin John | Geschäftsführer | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BEALES, Stuart Patrick | Geschäftsführer | Spring Road Market Weighton YO43 3JE York 28 North Yorkshire | United Kingdom | British | 136886810001 | |||||
| BRADNEY, James | Geschäftsführer | Unicorn House Broad Lane HU15 2TS Gilberdyke Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | 161101450001 | |||||
| CLARK, William Angus | Geschäftsführer | Folds Head Close Folds Head, Calver S32 3XJ Hope Valley Derbyshire | British | 80223540001 | ||||||
| FARMERY, Michael David | Geschäftsführer | 26 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley East Yorkshire | England | British | 19792670001 | |||||
| HARRIS, David Christopher | Geschäftsführer | 35 Carter Drive HU17 9GL Beverley East Yorkshire | England | British | 76088090001 | |||||
| HORNCASTLE, Andrew Nigel | Geschäftsführer | Beech Hill House Beech Hill Road Swanland HU14 3QY North Ferriby North Humberside | England | British | 4456360002 | |||||
| JACKSON, Terence William | Geschäftsführer | Beech Hill Road HU14 3QY Swanland The Hollies 7 East Yorkshire | Uk | British | 132410210001 | |||||
| MCCANN, Leah | Geschäftsführer | Flat 2 Merchants Warehouse Robinson Row HU1 2QX Hull East Yorkshire | British | 51908280001 | ||||||
| NEWTON, Christopher John Landsborough | Geschäftsführer | The Old Brewery Main Street YO61 2NS Helperby North Yorkshire | British | 101779200001 | ||||||
| SCANLAN, Sarah Rebecca | Geschäftsführer | 26 Northfield Avenue Hessle HU13 9DL Hull North Humberside | British | 55408650001 | ||||||
| TAYLOR, Malcolm | Geschäftsführer | 9 Copper Beech Close Dunnington YO19 5PY York North Yorkshire | England | British | 83888440001 | |||||
| TREBBLE, Stephen Paul | Geschäftsführer | The Laurels Main Street DN22 8DT Bothamsall Nottinghamshire | England | British | 76640730001 | |||||
| WHITE, Norman | Geschäftsführer | 19 Burnby Lane Pocklington YO42 2QB York North Yorkshire | British | 29472760001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat GATEWAY OFFSITE LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2009 Geliefert am 20. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 16. Nov. 2009 Geliefert am 20. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Nov. 2009 Geliefert am 18. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 2008 Geliefert am 18. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Sept. 2002 Geliefert am 19. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 12. Sept. 2002 Geliefert am 19. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 17. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 06. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0