RWM DORSET LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RWM DORSET LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03454792 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RWM DORSET LIMITED?
- Schlachtung, Verarbeitung und Konservierung von Fleisch (10110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich RWM DORSET LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Harlescott Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Shropshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RWM DORSET LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROMFORD WHOLESALE MEATS (DORSET) LIMITED | 20. Nov. 1997 | 20. Nov. 1997 |
| BROOMCO (1400) LIMITED | 24. Okt. 1997 | 24. Okt. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RWM DORSET LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RWM DORSET LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Janet Jennings als Sekretär am 02. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 01. Apr. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Notification of Rwm Food Group Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 02. Apr. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Francis Stephenson als Geschäftsführer am 16. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Thomas Francis Stephenson als Direktor am 30. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul John Finnerty als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul John Finnerty als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul John Finnerty als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 29. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RWM DORSET LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNINGS, Janet | Sekretär | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire | 282226050001 | |||||||
| MCLAUGHLIN, John | Sekretär | Rock Court Blackrock 9 County Louth Northern Ireland | 164135890001 | |||||||
| BURTON, John Michael | Geschäftsführer | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | England | British | 158694740001 | |||||
| KIRWAN, Thomas Joseph Lawrence, Mr. | Geschäftsführer | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | England | Irish | 53766120001 | |||||
| MICHAU, Peter James | Sekretär | 3 Littleworth Lane KT10 9PF Esher Lessworth Surrey | British | 35521130001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| COBDEN, Matthew Halsted | Geschäftsführer | Whitcombe Farm Ash TA12 6AH Martock Somerset | England | British | 35792480002 | |||||
| COBDEN, William Noel Halstead | Geschäftsführer | The Westover Bungalow Whitcombe Farm TA12 6AH Martock Somerset | British | 78312910001 | ||||||
| EASTWOOD, Mark | Geschäftsführer | 68 Marsh Lane BA21 3BY Yeovil Somerset | England | British | 105113870002 | |||||
| FINNERTY, Paul John | Geschäftsführer | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | Ireland | Irish | 138964760001 | |||||
| HEFFER, Graham Keith | Geschäftsführer | 14 Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 118776840001 | |||||
| HEFFER, Henry Robin | Geschäftsführer | Penthouse C 82 Lilliput Rd BH14 8LA Poole Forsyte Shades Dorset | United Kingdom | British | 49020560002 | |||||
| HEFFER, Robert Paul | Geschäftsführer | Mulberry House Laurel Drive BH18 8LJ Broadstone Dorset | United Kingdom | British | 49020570001 | |||||
| MURPHY, David | Geschäftsführer | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | Ireland | Irish | 164125330001 | |||||
| STEPHENSON, Thomas Francis | Geschäftsführer | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire | Ireland | Irish | 217150530001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RWM DORSET LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwm Food Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury . United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für RWM DORSET LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 24. Okt. 2016 | 06. März 2018 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat RWM DORSET LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 09. Aug. 2011 Geliefert am 19. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juli 2010 Geliefert am 21. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 14. Juli 2010 Geliefert am 15. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1000000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben New lamb slaughtering line s/n WP60071 & WP60072. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 16. Nov. 2006 Geliefert am 17. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Reiser UK LTD supervac GK812B & AT15E robins hawkins engineering LTD effluent plant WT50093-50096. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 05. Aug. 2003 Geliefert am 16. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The chattels the figa-bohn refridgeration equipment type PO73088/PP03814 (a) 2 x coolers SOP0015822 (a) SOP0015915 (a) 2 x condensing units SOP0015822(b) SOPP0015975(b), for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 05. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £104,400 and all other monies due or to become due from he company to the chargee under the terms of the mortgage | |
Kurze Angaben 1 x wbm 1350 conveyor vacuum packer with 1250 booster busch pump with serial no.6012HA110., 1 x stbw 60/80 electric shrink tunnel (72HA1606)., 1 x opal 6M conveyor and electrical control (OPD44779)., 1 x opal 1M conveyor and electrical control (A.22)., 1 x opal 3 tier packing container (A.33)., 1X opal 2M conveyor & electrical control no. Opo 44899., 1 x opal overhead roller track (A.11)., 1 x opal beef cutting line (A00). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Feb. 1999 Geliefert am 08. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the abbattoir chetnole road yetminster dorset t/no DT250109. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Mai 1998 Geliefert am 13. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0