TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03455961
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Field Court
    Grey's Inn
    WC1R 5EF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    16 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Dez. 2022

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Dez. 2021

    15 SeitenLIQ03

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    SeitenLIQ01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    SeitenLIQ01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Dez. 2020

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Merlin Place Milton Road Cambridge CB4 0DP zum 3 Field Court Grey's Inn London WC1R 5EF am 18. Dez. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Dez. 2019

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 03. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 752,200
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Merlin Place Milton Road Cambridge CB4 0DP verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 752,200
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 19. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 752,200
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BERNAYS, Rosamund
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    Sekretär
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    British55247520001
    BERNAYS, Richard Oliver
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    EnglandBritish98729980002
    BERNAYS, Rosamund
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Montevetro
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    E72
    United Kingdom
    EnglandBritish164310080001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Richard Oliver Bernays
    3 Field Court
    Grey's Inn
    WC1R 5EF London
    06. Apr. 2016
    3 Field Court
    Grey's Inn
    WC1R 5EF London
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 2011
    Geliefert am 07. Jan. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £216,713.00 being the sum of £200,000 due or to become due to the borrowers lender and all monies due or to become due from the borrower to donald ernest davies and winifred gladys davies under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H maidment house st leonards avenue blandford forum dorset.
    Berechtigte Personen
    • Gape Estates Limited, Quantum Homes Holdings Limited, Deep Valley Properties Limited, Lollesworth Property Limited and Adrian Coolbergen
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2010
    Geliefert am 24. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £213,945.50 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    9 selmeston road eastbourne t/no EB14298.
    Berechtigte Personen
    • Gape Estates Limited, Deep Valley Properties Limited, Lollesworth Property Limited and Adrian Coolbergen
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 2010
    Geliefert am 26. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H quackers duck street child okeford blandford forum t/no DT298640.
    Berechtigte Personen
    • Gape Estates Limited, Quantum Homes Holdings Limited, Deep Valley Properties Limited, Lollesworth Property Limited and Adrian Coolbergen
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2010
    Geliefert am 17. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 6 the old dairy hazelbury bryan dorset with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 2010
    Geliefert am 09. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, evershot construction limited, deep valley properties limited , starguard developments limited, gape estates limited and lollesworth property limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Shaftesbury house, land at the rear of yonder and a small strip of land affronting yonder, milldown road, blandford forum, dorset t/no's DT337475 and DT374695 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Jan. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 18-20 waterford lane lymington hampshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment by way of security
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Charges and agrees to charge to and in favour of the bank all the company's right title and interest present and future to in and arising out or in respect of the agreement and all rights, titles, benefits, monies receivable and interests of the company whatsoever (whether present, future, proprietary, contractual or otherwise); and by way of assignment by way of security the benefit of the agreement and all the company's entitlements to the receipt of all monies from time to time payable to it or receivable under the terms of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 17. Sept. 2001
    Geliefert am 20. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £600,000 deposited in the security account including any other sums which are deposited in the security account in addition to or by way of renewal of or replacement for such sum and all other monies from time to time standing to the security account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2000
    Geliefert am 16. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever and pursuant to the facility letter dated 2 august 2000
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the embassy hotel 26 gervis road bournemouth t/n DT239369. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Charge and assignment
    Erstellt am 04. Aug. 2000
    Geliefert am 11. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest present and future to in and arising out or in respect of the agreements and all rights titles benefits monies receivable and interests of the company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Parnership agreement
    Erstellt am 04. Aug. 2000
    Geliefert am 09. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The performance by the company of its obligations under the partnership agreement (as defined therein)
    Kurze Angaben
    The property k/a embassy hotel site, 26 gervis road, bournemouth t/n DT239369 and interest in the contracts entered into by the embassy partnership, insurance policies and the benefit of all WA0RANTIES and indemnifies to the partners in such partnership.
    Berechtigte Personen
    • Blarne Limited, Bradburian Developments Limited, Chevithorne Barton Limited, Church Farm Ryarsh Developments Limited, Draeken Limited, Green Meadows Limited Oakendell Developments Limited, Pons Developmenmts Limited, Richmond Peck Limitedtaikoo Developments Limited and West Down Proper
    • Ties Limited
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Charge and assignment by way of security
    Erstellt am 15. Dez. 1999
    Geliefert am 20. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in respect of the building contract (form jct 1998-private without quantities) dated 25 march 1999 and all rights titles benefits monies receivable and interests of the companies by way of assignment the benefit of the agreements see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 1999
    Geliefert am 20. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future indebtedness, monies obligations and liabilities of natpark limited, richmond peck limited, parkross limited and blarne limited ("the owning companies") and natpark limited, richmond peck limited, parkross limited, taikoo developments limited, west down properties limited and lollesworth property limited ("the companies") to the chargee pursuant to a facility letter dated 6TH september 1999 together with expenses and interest thereon and all other present and/or future indebtedness on any account and all other liabilities whatsoever and how so arising of the owning companies and/or the companies to the chargee present future actual and/or contingent and whether alone or jointly (including with any others in partnership) and whether as principal or surety or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge f/h 3 to 7 (odd) northburgh street and 41 to 53 (odd) goswell road islington london t/n-NGL768320 together with all fixtures and fittings and fixed plant and machinery from time to time on the property, any goodwill; by way of floating charge all unattached plant machinery chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment by way of security
    Erstellt am 01. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter
    Kurze Angaben
    The companys full title guarantee all rights titles benefits monies receivable and interests the full benefit of all guarantees, indemnities debentures, mortgages charges and other security and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Escrow account charge
    Erstellt am 01. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 10 june 1999
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge such interest as the companies may have from time to time in the deposit and the account and all entitlement to receive any monies at all in the account and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 10 june 1999
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the freehold property known as dunholme manor, 55 and 57 manor road bournemouth BH1 3EU title number DT253893 all fixtures and fittings and fixed plant and machinery any goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Partnership agreement comprising two agreements both
    Erstellt am 15. Okt. 1998
    Geliefert am 21. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The performance by the company of its obligations under the partnership agreement and supplemental partnership agreement each of even date
    Kurze Angaben
    The interest in common of the company in the property at and k/a 41-53 (odd numbers) goswell road and 3-7 (odd numbers) northburgh street london and the interest of the company in contracts entered into by the partnership. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natpark Limited Richmond Peck Limited Blarne Limited Lollesworth Property Limited Parkrosslimited and West Down Properties Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Partnership agreement
    Erstellt am 25. Nov. 1997
    Geliefert am 05. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee under the partnership agreement
    Kurze Angaben
    Property k/a dunholme manor bournemouth dorset. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chevithorne Barton Limited Draeken Limited Oakendell Developments Limited Pons Developmentslimited and Thistledown Developments Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Hat TAIKOO DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Mai 2023Soll aufgelöst werden am
    10. Dez. 2019Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praktiker
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0