F-M UK HOLDING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | F-M UK HOLDING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03459039 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von F-M UK HOLDING LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich F-M UK HOLDING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Wellington Place LS1 4AP Leeds West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von F-M UK HOLDING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SUPERGLORY LIMITED | 31. Okt. 1997 | 31. Okt. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von F-M UK HOLDING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für F-M UK HOLDING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Rsm Tenon Unit 1 Calder Close Calder Park Wakefield WF4 3BA am 16. Mai 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Federal-Mogul Limited Manchester Int'l Office Centre Styal Road Manchester M22 5TN United Kingdom am 08. Jan. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Beverley Ann Sutton als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Swift als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom T&N Limited Manchester International Office C, Styal Road Manchester Lancashire M22 5TN am 14. Dez. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 13 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 10. Okt. 2009 | 2 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von F-M UK HOLDING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUTTON, Beverley Ann | Sekretär | c/o Federal-Mogul Limited Manchester International Office Centre Styal Road M22 5TN Manchester Suite 14 Lancashire | British | 153006400001 | ||||||
HANGRAN, Loic Daniel | Geschäftsführer | Kronprinzenstrasse 65185 Weisbaden 14 Germany | Germany | French | Finance Director | 136200540001 | ||||
BOYDELL, Andrew Christopher | Sekretär | Hillside Farm Hangar Hill Whitwell S80 4SD Worksop Nottinghamshire | British | 640090001 | ||||||
JOHNSON, Alan Carl | Sekretär | 4240 St Andrews Howell Michigan Mi 48843 Usa | Usa | Executive Vice President | 45749680001 | |||||
ROBINSON, Patricia Josephine | Sekretär | 782 Warwick Road B91 3EH Solihull West Midlands | British | 58735060001 | ||||||
SWIFT, Elizabeth Shawcross | Sekretär | Mossdale Road M33 4FT Sale 22 Cheshire | British | Legal Assistant | 135544470001 | |||||
ZAMOYSKI, James | Sekretär | 7222 Meadowlake Road 48301 Bloomfield Hills Michigan Usa | American | 64040770001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BEATON, Paul | Geschäftsführer | 99 Heathway Heath CF14 4JS Cardiff | United Kingdom | Welsh | Financial Controller | 98957530001 | ||||
BOYDELL, Andrew Christopher | Geschäftsführer | Hillside Farm Hangar Hill Whitwell S80 4SD Worksop Nottinghamshire | British | Legal Adviser | 640090001 | |||||
BOZYNSKI, David Anthony | Geschäftsführer | 1665 Quarton Road Birmingham Michigan 48009 Usa | American | Vp & Cfo | 69772630001 | |||||
DAVIS, George | Geschäftsführer | 4 Hillcot Close Lisvane CF14 0TN Cardiff | British | General Manager | 2252930002 | |||||
DEVONALD, John Hamilton | Geschäftsführer | Mill Farm House Goodshawfold Road BB4 8QN Rossendale Lancashire | British | Chartered Accountant | 46691030001 | |||||
DEVONALD, John Hamilton | Geschäftsführer | Mill Farm House Goodshawfold Road BB4 8QN Rossendale Lancashire | British | Chartered Accountant | 46691030001 | |||||
JOHNSON, Alan Carl | Geschäftsführer | 4240 St Andrews Howell Michigan Mi 48843 Usa | Usa | Executive Vice President | 45749680001 | |||||
RYAN, Thomas Winfield | Geschäftsführer | 287 Lone Pine Road MI 48304 Bloomfield Hills Michigan Usa | Usa | Senior Vice President & Cfo | 55989920001 | |||||
SHERBIN, David Matthew | Geschäftsführer | 4181 Southmoor Lane West Bloomfield Michigan 48323 United States | American | Attorney | 77513330001 | |||||
SNELL, Richard Arthur | Geschäftsführer | 459 Martell Drive MI 48304 Bloomfield Hills Michigan Usa | Usa | Chairman President And Ceo | 55990010002 | |||||
THOMAS, Kevin Patrick | Geschäftsführer | 35 Avenue Road TW18 3AW Staines Middlesex | British | Manager | 14061980001 | |||||
VERWILST, Michael Craig | Geschäftsführer | 5629 Kirkridge Trail Rochester Hills Michigan United States | American | Vice-President Powertrain Syst | 66396890001 | |||||
ZAMOYSKI, James | Geschäftsführer | 7222 Meadowlake Road 48301 Bloomfield Hills Michigan Usa | American | Senior Vice President & Genera | 64040770001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat F-M UK HOLDING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of mortgage of shares | Erstellt am 27. Dez. 2007 Geliefert am 31. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each loan party to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the shares and related rights any dividend interest or other distribution paid or payable and any right. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 19. Feb. 2001 Geliefert am 23. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (including the deed of charge) in relation to the public debt obligations,the cash management obligations,the surety bond obligations and the trustee fees | |
Kurze Angaben 44,850,000 of £1 each in the capital of federal-mogul global growth limited together with all rights dividends interest principal and other payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 03. Nov. 1999 Geliefert am 04. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each obligation of the company to the chargee under the terms of the finance documnts | |
Kurze Angaben 44,850,000 shares of £1 each in capital of federal-mogul global growth limited together with all rights attaching to or conferred by the shares all dividends interest and other payments accruing therefrom including bonus and rights issue. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 06. Jan. 1999 Geliefert am 12. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee, the administrative agent and/or the trustee under or pursuant to the finance documents and all obligations and liabilities due in respect of the public debt obligations (as defined) and the esop guaranty obligations (as defined) | |
Kurze Angaben 29,152,500 shares of £1 each in the capital of federal-mogul global growth limited together with all of the rights attaching to or conferred by such shares all payments of dividends interest principal and other payments of money. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 22. Juli 1998 Geliefert am 30. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every obligation which the company may now or hereafter have to the chargee due under or pursuant to the facility documents | |
Kurze Angaben 29,152,500 shares of £1 each in the capital of federal-mogul global growth limited together with all of the rights attaching to or conferred by such shares,all payments of dividends,interest,principal and other payments of money and any rights thereto forming part of such shares and all shares issued by way of bonus or rights issue or to which the company otherwise becomes entitled.all of the company's right,title and interest in and to the inter-company loan dated 12 march 1998 made by the company to federal-mogul global growth limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat F-M UK HOLDING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Verwaltungsordnung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0