VARLEY PUMPS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVARLEY PUMPS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03467902
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VARLEY PUMPS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich VARLEY PUMPS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VARLEY PUMPS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DE FACTO 678 LIMITED18. Nov. 199718. Nov. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VARLEY PUMPS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für VARLEY PUMPS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2018

    2 SeitenAA

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2018 bis 31. Mai 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Hayward Tyler Group Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Ewan Royston Lloyd Baker als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Michael King als Direktor am 31. Aug. 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 19. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Specialist Energy Group Plc 19 Crown Passage London SW1Y 6PP United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    14 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von VARLEY PUMPS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KING, Stephen Michael
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    EnglandBritish84235400004
    BALLENTINE, Norman Mcara
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    Sekretär
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    British77926160001
    COESHALL, Elizabeth
    Newland Street
    CM8 1AH Witham
    72a
    Essex
    United Kingdom
    Sekretär
    Newland Street
    CM8 1AH Witham
    72a
    Essex
    United Kingdom
    Other139443050001
    GRAY, Claire Laura
    Shire Barn, School Road
    Copford Green, Copford
    CO6 1BZ Colchester
    Sekretär
    Shire Barn, School Road
    Copford Green, Copford
    CO6 1BZ Colchester
    British32016350003
    JACKSON, Kim Lee
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British63570400001
    KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr.
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    Sekretär
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    British70888320002
    LANGRIDGE, Nicola Jane
    32 Seamons Close
    LU6 3EQ Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    32 Seamons Close
    LU6 3EQ Dunstable
    Bedfordshire
    British59986880001
    LEWIS, Liza Marie
    32 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxfordshire
    Sekretär
    32 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxfordshire
    British65894530001
    MALONEY, Adam Paul
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    Sekretär
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    British62655860001
    RIDLEY, Ian
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    British56015010001
    SMITH, Robin Oliver
    31 Howes Drive
    Marston Moretaine
    MK43 0FD Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    31 Howes Drive
    Marston Moretaine
    MK43 0FD Bedford
    Bedfordshire
    British75404030002
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Sekretär
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Bevollmächtigter Sekretär
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BALLENTINE, Norman Mcara
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    British77926160001
    DART, Geoffrey Gilbert
    103a Ashley Gardens
    Thirleby Road
    SW1P 1HJ London
    Geschäftsführer
    103a Ashley Gardens
    Thirleby Road
    SW1P 1HJ London
    EnglandBritish76453360007
    GREENWELL, Kevin
    234 Cutenhoe Road
    LU3 4DU Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    234 Cutenhoe Road
    LU3 4DU Luton
    Bedfordshire
    British56015980002
    JACKSON, Kim Lee
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British63570400001
    KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr.
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish70888320002
    LLOYD BAKER, Ewan Royston
    Beecham House
    The Street West Winterlow
    SP5 1RY Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Beecham House
    The Street West Winterlow
    SP5 1RY Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish102945080001
    MALONEY, Adam Paul
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    British62655860001
    RIDLEY, Ian
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    British56015010001
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Geschäftsführer
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    WEARING, Gary
    77 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    77 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    British65188100001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VARLEY PUMPS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Kimpton Road
    LU1 3LD Luton
    1
    England
    06. Apr. 2016
    Kimpton Road
    LU1 3LD Luton
    1
    England
    Nein
    RechtsformCompany
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3232768
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat VARLEY PUMPS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Nov. 2006
    Geliefert am 02. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2006
    Geliefert am 30. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 02. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3ITMENT Partners LP(for Further Details of Chargee
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3IS See from 395)
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3IINVESTMENT Partners LP) 3I Group PLC,3I UK Inves
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    All assets debenture
    Erstellt am 06. März 2006
    Geliefert am 15. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1997
    Geliefert am 29. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor,guarantor,surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of hayward tyler group limited (formerly known as de facto 521 limited) and its subsidiary undertakings from time to time to 3I PLC (the "security trustee") and/or 3I group PLC and 3I UK investment partners and any person who is designated a lender under clause 23 of the mezzanine loan agreement (as defined) in whatever manner and on any account including,but not limited to,under the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1997
    Geliefert am 19. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the chargee in whatever manner and on any account including but not limited to the financing documents together with all costs, charges and expenses incurred by the chargee in connection with the protection, preservation or enforcement of its rights under the financing documents or otherwise
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0