VARLEY PUMPS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VARLEY PUMPS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03467902 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VARLEY PUMPS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich VARLEY PUMPS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Kimpton Road Luton LU1 3LD Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VARLEY PUMPS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DE FACTO 678 LIMITED | 18. Nov. 1997 | 18. Nov. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VARLEY PUMPS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VARLEY PUMPS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2018 bis 31. Mai 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Hayward Tyler Group Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ewan Royston Lloyd Baker als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Michael King als Direktor am 31. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Specialist Energy Group Plc 19 Crown Passage London SW1Y 6PP United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VARLEY PUMPS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING, Stephen Michael | Geschäftsführer | 1 Kimpton Road Luton LU1 3LD Bedfordshire | England | British | 84235400004 | |||||
| BALLENTINE, Norman Mcara | Sekretär | 5 Ashdale Park RG40 3QS Finchampstead Berkshire | British | 77926160001 | ||||||
| COESHALL, Elizabeth | Sekretär | Newland Street CM8 1AH Witham 72a Essex United Kingdom | Other | 139443050001 | ||||||
| GRAY, Claire Laura | Sekretär | Shire Barn, School Road Copford Green, Copford CO6 1BZ Colchester | British | 32016350003 | ||||||
| JACKSON, Kim Lee | Sekretär | 1 Curzon Place Old Farm Park MK7 8RB Milton Keynes Buckinghamshire | British | 63570400001 | ||||||
| KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr. | Sekretär | 21 West End Brampton PE28 4SD Huntingdon Cambridgeshire | British | 70888320002 | ||||||
| LANGRIDGE, Nicola Jane | Sekretär | 32 Seamons Close LU6 3EQ Dunstable Bedfordshire | British | 59986880001 | ||||||
| LEWIS, Liza Marie | Sekretär | 32 Ravencroft OX6 0YQ Bicester Oxfordshire | British | 65894530001 | ||||||
| MALONEY, Adam Paul | Sekretär | 65 Trajan Gate SG2 7QQ Stevenage Hertfordshire | British | 62655860001 | ||||||
| RIDLEY, Ian | Sekretär | 8 The Crest LU3 2LE Luton Bedfordshire | British | 56015010001 | ||||||
| SMITH, Robin Oliver | Sekretär | 31 Howes Drive Marston Moretaine MK43 0FD Bedford Bedfordshire | British | 75404030002 | ||||||
| WALTERS, Nicholas John | Sekretär | 8 Garrick Avenue Newton Mearns Mearnskirk G77 5GF Glasgow | British | 38462890002 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Bevollmächtigter Sekretär | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 | |||||||
| BALLENTINE, Norman Mcara | Geschäftsführer | 5 Ashdale Park RG40 3QS Finchampstead Berkshire | British | 77926160001 | ||||||
| DART, Geoffrey Gilbert | Geschäftsführer | 103a Ashley Gardens Thirleby Road SW1P 1HJ London | England | British | 76453360007 | |||||
| GREENWELL, Kevin | Geschäftsführer | 234 Cutenhoe Road LU3 4DU Luton Bedfordshire | British | 56015980002 | ||||||
| JACKSON, Kim Lee | Geschäftsführer | 1 Curzon Place Old Farm Park MK7 8RB Milton Keynes Buckinghamshire | British | 63570400001 | ||||||
| KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr. | Geschäftsführer | 21 West End Brampton PE28 4SD Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 70888320002 | |||||
| LLOYD BAKER, Ewan Royston | Geschäftsführer | Beecham House The Street West Winterlow SP5 1RY Salisbury Wiltshire | England | British | 102945080001 | |||||
| MALONEY, Adam Paul | Geschäftsführer | 65 Trajan Gate SG2 7QQ Stevenage Hertfordshire | British | 62655860001 | ||||||
| RIDLEY, Ian | Geschäftsführer | 8 The Crest LU3 2LE Luton Bedfordshire | British | 56015010001 | ||||||
| WALTERS, Nicholas John | Geschäftsführer | 8 Garrick Avenue Newton Mearns Mearnskirk G77 5GF Glasgow | British | 38462890002 | ||||||
| WEARING, Gary | Geschäftsführer | 77 Hampden Road SG4 0LB Hitchin Hertfordshire | British | 65188100001 | ||||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006090001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VARLEY PUMPS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayward Tyler Group Limited | 06. Apr. 2016 | Kimpton Road LU1 3LD Luton 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VARLEY PUMPS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Nov. 2006 Geliefert am 02. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Nov. 2006 Geliefert am 30. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 02. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 06. März 2006 Geliefert am 15. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Dez. 1997 Geliefert am 29. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor,guarantor,surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of hayward tyler group limited (formerly known as de facto 521 limited) and its subsidiary undertakings from time to time to 3I PLC (the "security trustee") and/or 3I group PLC and 3I UK investment partners and any person who is designated a lender under clause 23 of the mezzanine loan agreement (as defined) in whatever manner and on any account including,but not limited to,under the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Dez. 1997 Geliefert am 19. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the chargee in whatever manner and on any account including but not limited to the financing documents together with all costs, charges and expenses incurred by the chargee in connection with the protection, preservation or enforcement of its rights under the financing documents or otherwise | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0