SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED

SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSERCO INSURANCE SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03471126
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    ERNST & YOUNG LLP
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PUCKLECHURCH CUSTODIAL (HOLDINGS) LIMITED15. Dez. 199715. Dez. 1997
    ALNERY NO.1693 LIMITED25. Nov. 199725. Nov. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2009

    5 Seiten4.68

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Sept. 2008

    LRESSP

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    10 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SERCO CORPORATE SERVICES LIMITED
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    115898490001
    LEACH, Guy William
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    EnglandBritish70877660005
    WYATT, Michael
    33 New Road
    Twyford
    RG10 9PS Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    33 New Road
    Twyford
    RG10 9PS Reading
    Berkshire
    British106350420001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Sekretär
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    British56835390001
    COOKE, David John
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    Sekretär
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    British83213800001
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Sekretär
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BAILEY, Carol Elaine
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    Geschäftsführer
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    British93650840001
    BAILEY, Carol Elaine
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    Geschäftsführer
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    EnglandBritish9905530001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Geschäftsführer
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United KingdomBritish56835390001
    CALABRESE, Wayne Howard
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    Geschäftsführer
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    United StatesAmerican30780670003
    CARTER, James Duncan
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    British93908800001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish3471920001
    EDWARDS, Philip John
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    Geschäftsführer
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    British87032350001
    FUTCHER, William Frank
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    British51346890001
    HAYWARD, Neil
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    British144924760001
    HILL, Gavin
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pine Ridge House
    4 Bourne Grove Close Lower Bourne
    GU10 3RA Farnham
    Surrey
    EnglandBritish84457250002
    JEFFERY, John Daniel Michael
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    British93851850002
    KEENS, Donald Herbert
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    Geschäftsführer
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    British70256340003
    LEACH, Guy William
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    Geschäftsführer
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    British70877660003
    LEWIS, Kevin Tony
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Geschäftsführer
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian86468730001
    LEWIS, Kevin Tony
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Australian52036330001
    RIALL, Thomas Richard Phineas
    Middle Farm
    Ufton Nervet
    RG7 4HE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Middle Farm
    Ufton Nervet
    RG7 4HE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish76434190001
    SMITH, John
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    British95897660001
    TAIYEB, Serajul Islam
    14 Swan Lane
    IG10 4QW Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Swan Lane
    IG10 4QW Loughton
    Essex
    British36414160002
    TASKER, Ronald
    Belt Farm
    Laytham
    YO42 4PR York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Belt Farm
    Laytham
    YO42 4PR York
    Yorkshire
    British93929470001
    ZOLEY, George Christopher
    15 Senca Road
    33308 Sea Ranch Lakes
    Florida
    Usa
    Geschäftsführer
    15 Senca Road
    33308 Sea Ranch Lakes
    Florida
    Usa
    American56393460001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    Hat SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Subordinated deed of charge
    Erstellt am 07. Apr. 1999
    Geliefert am 10. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from pucklechurch custodial services limited or the company to the chargees in any manner whatsoever unless otherwise provided for in the financing agreements under each or any of the financing agreements
    Kurze Angaben
    200,000 ordinary shares in the share capital of pucklechurch custodial services and all other securities and distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Serco Investments Limited(As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over shares and securities
    Erstellt am 01. Juli 1998
    Geliefert am 20. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness (in whatever currency it may be expressed) of pucklehurst custodial services limited or the company to any of the finance parties (whether incurred solely severally or jointly with others and whether incurred as principal or surety) under each or any of the financing agreements
    Kurze Angaben
    By way of equitable mortgage 200,000 ordinary shares in the capital of pcs together with the securities all distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandin Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 20. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SERCO INSURANCE SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Feb. 2010Aufgelöst am
    05. Sept. 2008Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Lynne Trigg
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0