MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03471396 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AMBIENT ENERGY LIMITED | 12. Dez. 1997 | 12. Dez. 1997 |
PLEDGEPOWER LIMITED | 26. Nov. 1997 | 26. Nov. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Huw Griffiths als Geschäftsführer am 02. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Dez. 2020 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 16 st Martins Le Grand St Martins House London EC1A 4EN verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 16 st Martins Le Grand St Martins House London EC1A 4EN geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Morton Fraser 16 st. Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN England zum 1 More London Place London SE1 2AF am 08. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Mel Zuydam als Geschäftsführer am 01. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Juni 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Mel Zuydam als Direktor am 11. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katerina Brown als Geschäftsführer am 04. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Leitch Mackenzie als Geschäftsführer am 30. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Feb. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew William Lee als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Alan Walters als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 15 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246090001 | |||||||||||
BISSET, Graham Ferguson | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566980001 | |||||||||||
CALDER, Samantha Jane | Sekretär | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
HULLEY, Christine Wyn | Sekretär | 2 Felltop Drive Reddish Vale SK5 6YS Stockport Cheshire | British | 35745290001 | ||||||||||
KENNA, Jeffrey Paul, Dr | Sekretär | Overmoor Farm Neston SN13 9TZ Corsham Wiltshire | British | Director | 2042580002 | |||||||||
LONG, Jacqueline | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204212660001 | |||||||||||
MITCHELL, Christopher John | Sekretär | 53 Stoke Lane Westbury On Trym BS9 3DW Bristol | British | 19750010001 | ||||||||||
OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Sekretär | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||||||
FNCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011830001 | |||||||||||
OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | Finance Director | 294355310001 | ||||||||
BART, Stephen Leonard | Geschäftsführer | 311 Lakeside Greens Court Chestermere Alberta T1x 1c8 Canada | Canadian | Director | 85735170001 | |||||||||
BOYD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 148856600001 | ||||||||
BROWN, John Ernest | Geschäftsführer | 10 Stonegate Fold Heath Charnock PR6 9DX Chorley Lancashire | England | British | Certified Accountant | 11806560001 | ||||||||
BROWN, Katerina | Geschäftsführer | 16 St. Martin's Le Grand St Martins House EC1A 4EN London C/O Morton Fraser England | Scotland | British | Accountant | 232165890001 | ||||||||
DAUCE, David Peter | Geschäftsführer | 16 Abbotts Walk GL7 3DB Lechlade Gloucestershire | British | Commercial Director | 7304980001 | |||||||||
EDWARDS, Mark Simon | Geschäftsführer | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | Gm - Finance | 109659860001 | |||||||||
FITZSIMMONS, David Stephen | Geschäftsführer | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Ceo | 109928450001 | ||||||||
GANNON, Shane Michael | Geschäftsführer | 42 Riverside Drive Sandringham New South Wales 2219 Australia | Australian | Director | 86673690001 | |||||||||
GANNON, Shane Michael | Geschäftsführer | 42 Riverside Drive Sandringham New South Wales 2219 Australia | Australian | Director | 86673690001 | |||||||||
GRIFFITHS, David Huw | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand ECA1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp United Kingdom | United Kingdom | British | Coo | 177733400003 | ||||||||
HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | Solicitor | 93743250007 | ||||||||
HEWSON, John Francis | Geschäftsführer | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | Development Director | 120308140001 | ||||||||
HINTON, Thomas Edward | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | England | British | Chief Finance Officer | 238940970001 | ||||||||
KAY, Ian Andrew | Geschäftsführer | 17 Jenner Street Seaforth New South Wales 2092 Australia | British | Investment Banker | 102259090001 | |||||||||
KENNA, Jeffrey Paul, Dr | Geschäftsführer | Overmoor Farm Neston SN13 9TZ Corsham Wiltshire | England | British | Energy | 2042580002 | ||||||||
LEE, Andrew William | Geschäftsführer | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House United Kingdom | United Kingdom | British | Energy Finance Professional | 87527870001 | ||||||||
MACHIELS, Eric Philippe Marianne, Dr | Geschäftsführer | 16 St. Martin's Le Grand St Martins House EC1A 4EN London C/O Morton Fraser England | United Kingdom | Belgium | Director | 125748990001 | ||||||||
MACKENZIE, Scott Leitch | Geschäftsführer | 16 St. Martin's Le Grand St Martins House EC1A 4EN London C/O Morton Fraser England | Scotland | British | Director | 277478140001 | ||||||||
MILLER, David Muir | Geschäftsführer | The Old Boat House Inn 1 Warrington Lane WA13 0UH Lymm Cheshire | United Kingdom | British | Ceo | 69864850004 | ||||||||
NAGLE, Michael | Geschäftsführer | 16 St. Martin's Le Grand St Martins House EC1A 4EN London C/O Morton Fraser England | United Kingdom | British | Company Director | 29436380007 | ||||||||
QUINLAN, Rory John | Geschäftsführer | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | Cfo | 113941780001 | |||||||||
ROUND, Richard Calvin | Geschäftsführer | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | Finance Director | 108158250002 | ||||||||
SCAYSBROOK, David Andrew | Geschäftsführer | 7 Durrington Park Road Wimbledon SW20 8NU London | Australian | Executive Chairman | 97490770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infinis Wind Holdings Limited | 30. Apr. 2017 | 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2017 Geliefert am 29. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2013 Geliefert am 11. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2012 Geliefert am 21. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Jan. 2005 Geliefert am 20. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 05. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from nm renewable energy (holdings 2) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 07. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0