RAL REALISATIONS 2011 LIMITED

RAL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRAL REALISATIONS 2011 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03474127
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    • (3614) /
    • (3615) /

    Wo befindet sich RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    REST ASSURED LIMITED29. Jan. 199829. Jan. 1998
    PINCO 996 LIMITED01. Dez. 199701. Dez. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Jan. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2011

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 700,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Paul Mckoen als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Mckoen als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Mckoen als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed rest assured LIMITED\certificate issued on 15/06/11
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 08. Juni 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    12 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Jan. 2010

    17 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Neal Gerard Mernock am 06. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Seth Mckoen am 06. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Seth Mckoen am 06. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    21 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Feb. 2008

    22 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MERNOCK, Neal Gerard
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    Geschäftsführer
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director67905570005
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    British106771550001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    Sekretär
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    British68949300004
    HOPE, Richard Geoffrey
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    Sekretär
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    British32541300001
    JONES, Robert Glyn
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    British116871110002
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Sekretär
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    BritishCompany Director49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Sekretär
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    ScottishCompany Secretary146642810001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector106771550001
    ALLENZA, Antonino
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    BritishCompany Director39237330004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    CLARK, Andrew William
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomEnglishManaging Director102836380001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor68949300004
    GILL, Stephen Paul
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    BritishDirector59486300001
    IDDON, Joanne
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant92755390001
    MCILROY, Michael
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    BritishCompany Director63014400001
    MCKENZIE, Barry
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    Geschäftsführer
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    BritishChartered Accountant1164360001
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Geschäftsführer
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    EnglandBritishCompany Director49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottishCompany Secretary146642810001
    SCOTT, Michelle
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    BritishCompany Director51740980003
    SIMPSON, William
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director14163900002
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director36252860002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    Hat RAL REALISATIONS 2011 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Feb. 2011
    Geliefert am 18. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cahrgors to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Grace Bay Ii Holdings Sarl
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 29. Jan. 2004
    Geliefert am 07. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0