LIFE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLIFE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03474139
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LIFE LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich LIFE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LIFE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PINCO 999 LIMITED01. Dez. 199701. Dez. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIFE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Feb. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für LIFE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Philip Hedley Bowcock als Geschäftsführer am 14. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Terence Douglas als Direktor am 14. Nov. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Aug. 2011

    Kapitalaufstellung am 16. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 3,330,224
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Philip Hedley Bowcock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Jayne Fearn als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    23 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Feb. 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Marks als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Luminar Leisure Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Feb. 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    9 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2008

    10 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von LIFE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Sekretär
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158741750001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Geschäftsführer
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03802937
    152128400001
    FRIEND, Lynne
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    British59349000001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Sekretär
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    PORTER, Hugh Leslie
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    Sekretär
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    British63443690001
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    British44233980001
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Sekretär
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    THORPE, Elizabeth Anne
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    Sekretär
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    British63473530001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ANDREW, Derek
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    British66854930001
    BACON, Timothy Alan
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    EnglandBritish66652780001
    BARRATT, Simon Charles
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish14044440005
    BONNELL, William Andrew
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    Geschäftsführer
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    British101547740001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Geschäftsführer
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BUCHAN, William James
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    EnglandBritish79917240001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Geschäftsführer
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    HINDS, John David
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    Geschäftsführer
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    United KingdomBritish83825290003
    JONES, Mark Vincent
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British81765510001
    LIVINGSTONE, David Barry Hindle
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    British142596910001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Geschäftsführer
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish44233980002
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    TAYLOR, Andrew Herbert Ian
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    Geschäftsführer
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    United KingdomBritish116794160001
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    Hat LIFE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 08. Dez. 2010
    Geliefert am 15. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of mortgage property please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtrues, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed creating a floating charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 30. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditors
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 23. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge its undertaking and all assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 1999
    Geliefert am 25. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H licensed premises k/a 1A bold street liverpool and any proceeds of sale and all buildings and fixtures (including trade fixtures), the insurance policy taken out in respect of the property, the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 13. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities now or hereafer due, owing or incurred by the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage: outside front - 10, stainless steel effect pedestal pavement cafe tables on pedestal supports with splayed feet. 34, stainless steel effect open arm pavement chairs with black woven seats and backs. Raised patio section - 4, ditto stainless steel pedestal tables.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 1998
    Geliefert am 10. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0