LIFE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LIFE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03474139 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LIFE LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich LIFE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LIFE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 999 LIMITED | 01. Dez. 1997 | 01. Dez. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIFE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 25. Feb. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LIFE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Hedley Bowcock als Geschäftsführer am 14. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Terence Douglas als Direktor am 14. Nov. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Hedley Bowcock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jayne Fearn als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 23 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Feb. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Marks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Luminar Leisure Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Feb. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 395 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LIFE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEARN, Jayne | Sekretär | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks | 158741750001 | |||||||||||
| DOUGLAS, Simon Terence | Geschäftsführer | Coopers Green Lane AL4 9HR St. Albans Oak House Hertfordshire England | England | British | 89567300002 | |||||||||
| LUMINAR LEISURE LIMITED | Geschäftsführer | Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Luminar House England |
| 152128400001 | ||||||||||
| FRIEND, Lynne | Sekretär | Windborne House Ashbourne Road Turnditch DE56 2LH Derby Derbyshire | British | 59349000001 | ||||||||||
| MORRIS, David Charles | Sekretär | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | 98815770001 | ||||||||||
| O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Sekretär | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 55241590004 | ||||||||||
| PARSONS, Steven Ian | Sekretär | 13 Moreton Road South Round Green LU2 0TL Luton Bedfordshire | British | 87152410003 | ||||||||||
| PORTER, Hugh Leslie | Sekretär | Hawthorn House Badger Road, Beckbury TF11 9DQ Shifnal Salop | British | 63443690001 | ||||||||||
| ROBERTS, Jeremy Kevin | Sekretär | 29 River Street SK9 4AB Wilmslow Cheshire | British | 44233980001 | ||||||||||
| STRIDE, Andrew William | Sekretär | 6 Tilbury Road East Haddon NN6 8BX Northampton | British | 62422770001 | ||||||||||
| THORPE, Elizabeth Anne | Sekretär | 85 Silverdale Road Earley RG6 7NF Reading Berkshire | British | 63473530001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013300001 | |||||||||||
| ANDREW, Derek | Geschäftsführer | Church Hill House Church Hill, Kinver DY7 6HY Stourbridge West Midlands | British | 66854930001 | ||||||||||
| BACON, Timothy Alan | Geschäftsführer | Chantry Cottage Brookhouse Green CW11 2XF Smallwood Cheshire | England | British | 66652780001 | |||||||||
| BARRATT, Simon Charles | Geschäftsführer | Longwood Langton Green TN3 0BA Tunbridge Wells Kent | England | British | 14044440005 | |||||||||
| BONNELL, William Andrew | Geschäftsführer | Ferry Lane Barn Ferry Road RG8 0JL South Stoke | British | 101547740001 | ||||||||||
| BOWCOCK, Philip Hedley | Geschäftsführer | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks | England | British | 158744440001 | |||||||||
| BROWN, Gary | Geschäftsführer | Holly Tree House CV23 8AT Flecknoe Warwicks | British | 94339190002 | ||||||||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Winkworth Grange Hascombe Road South Munstead GU8 4AD Godalming Surrey | England | British | 79917240001 | |||||||||
| BURFORD, Alistair Graham | Geschäftsführer | The Jungle Madingley Road, Coton CB23 7PH Cambridge | England | British | 124289050002 | |||||||||
| BURNS, Andrew Rae | Geschäftsführer | 11 Glebe Avenue EN2 8NZ Enfield Middlesex | England | British | 54722740002 | |||||||||
| FENNEY, Paul Francis | Geschäftsführer | Porch House Church Street Buckden PE19 5SX St Neots Cambridgeshire | United Kingdom | British | 97980790001 | |||||||||
| HINDS, John David | Geschäftsführer | The Granary Lower Wallington LL13 0AN Worthenbury Wrexham | United Kingdom | British | 83825290003 | |||||||||
| JONES, Mark Vincent | Geschäftsführer | 5 Lake View Moor Hall Lane St Michaels Head CM23 4GZ Bishops Stortford Hertfordshire | British | 81765510001 | ||||||||||
| LIVINGSTONE, David Barry Hindle | Geschäftsführer | Lakeside 20 Lakeside Road WA13 0QE Lymm Cheshire | British | 142596910001 | ||||||||||
| MARKS, Andrew Geoffrey | Geschäftsführer | 170 Long Meadow Bedgrove HP21 7EB Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | 98760390001 | |||||||||
| MORRIS, David Charles | Geschäftsführer | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | 98815770001 | ||||||||||
| O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Geschäftsführer | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 55241590004 | |||||||||
| ROBERTS, Jeremy Kevin | Geschäftsführer | Wyndcroft Adlington Road SK9 2AL Wilmslow Cheshire | England | British | 44233980002 | |||||||||
| SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||||||
| TAYLOR, Andrew Herbert Ian | Geschäftsführer | 10 Aldwycks Close MK5 6HZ Milton Keynes | United Kingdom | British | 116794160001 | |||||||||
| THOMAS, Stephen Charles | Geschäftsführer | Newnham Hall Poets Way, Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 66198390004 | ||||||||||
| WILLITS, Henry Andrew | Geschäftsführer | Stable Barn Hall Farm Charwelton Road NN11 3TA Preston Capes Northamptonshire | British | 90132600002 | ||||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013290001 |
Hat LIFE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Dez. 2010 Geliefert am 15. Dez. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of mortgage property please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtrues, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 27. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 27. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed creating a floating charge | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 27. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 15. Aug. 2007 Geliefert am 30. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 16. Dez. 2004 Geliefert am 22. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 23. Juli 2004 Geliefert am 04. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge its undertaking and all assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Jan. 1999 Geliefert am 25. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H licensed premises k/a 1A bold street liverpool and any proceeds of sale and all buildings and fixtures (including trade fixtures), the insurance policy taken out in respect of the property, the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 13. Jan. 1999 Geliefert am 19. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities now or hereafer due, owing or incurred by the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage: outside front - 10, stainless steel effect pedestal pavement cafe tables on pedestal supports with splayed feet. 34, stainless steel effect open arm pavement chairs with black woven seats and backs. Raised patio section - 4, ditto stainless steel pedestal tables.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1998 Geliefert am 10. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0