STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03477150 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Atlantic Street Broadheath WA14 5FY Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HEADWORX (EUROPE) LIMITED | 05. Dez. 1997 | 05. Dez. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Grenville Rusby am 27. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Grenville Rusby am 27. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2)R | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 123 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2003 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSBY, Peter Grenville | Sekretär | Atlantic Street Broadheath WA14 5FY Altrincham Cheshire | British | 16859340003 | ||||||
| BENTWOOD, Steven Michael | Geschäftsführer | Bankhall Corner 110 Bankhall Lane WA15 0DH Hale Cheshire | United Kingdom | British | 93615070002 | |||||
| RUSBY, Peter Grenville | Geschäftsführer | Atlantic Street Broadheath WA14 5FY Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 16859340004 | |||||
| WHITE, Angela Frances | Sekretär | Little Bourne Shewte Cross TQ13 9LQ Bovey Tracey Devon | British | 48383080001 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| GOWER, David Kevin | Geschäftsführer | Little Bown Shewte Cross TQ13 9LQ Bovey Tracey Devon | British | 37899800002 | ||||||
| SOLOMON, Peter Loris | Geschäftsführer | House 127, The Portofino 88-188 Pak To Avenue Clearwater Bay Sai Kung New Territories Hong Kong | Australian | 111531540004 | ||||||
| WHITE, Angela Frances | Geschäftsführer | Little Bourne Shewte Cross TQ13 9LQ Bovey Tracey Devon | British | 48383080001 | ||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Hat STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Nov. 2001 Geliefert am 14. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 29. Juni 2001 Geliefert am 04. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement or otherwise | |
Kurze Angaben (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juli 2000 Geliefert am 31. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 06. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed equitable charge over all debts purchased with all associated rights thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0