FAREBROTHER GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFAREBROTHER GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03477861
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 04. Juli 2012

    • Kapital: GBP 67,492
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Michael Smith am 14. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Arthur Edward Gee am 14. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Edwards am 14. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Martin Paul Wrigley am 14. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    22 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten155(6)b

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    legacy

    9 Seiten155(6)a

    Wer sind die Geschäftsführer von FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WRIGLEY, Martin Paul
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Sekretär
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    British114395980001
    EDWARDS, John
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Geschäftsführer
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish60296400001
    GEE, Arthur Edward
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Geschäftsführer
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish60296640001
    BROMLEY, Tracey Helen
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    Sekretär
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    British49508780002
    STEWARD, Karen Mary
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    British60296780002
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BROMLEY, Tracey Helen
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    Geschäftsführer
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    British49508780002
    EDWARDS, John
    17 Moss Bank Road
    Swinton
    M27 9UJ Manchester
    Geschäftsführer
    17 Moss Bank Road
    Swinton
    M27 9UJ Manchester
    EnglandBritish60296400001
    JOHNSON, John
    17 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish100740730001
    PEAKE, John
    7 Orrishmere Road
    SK8 5HP Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    7 Orrishmere Road
    SK8 5HP Cheadle Hulme
    Cheshire
    British74261470001
    SMITH, Martin Philip
    3 The Circuit
    Cheadle Hulme Cheadle
    SK3 9RN Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 The Circuit
    Cheadle Hulme Cheadle
    SK3 9RN Stockport
    Cheshire
    British87763320001
    SMITH, Michael
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Geschäftsführer
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish114796520004
    STEWARD, John
    Windsor House 24 Werneth Road
    Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Windsor House 24 Werneth Road
    Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish55224920003
    STEWARD, Karen Mary
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    British60296780002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Hat FAREBROTHER GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All payments as rent under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial mortgage deed
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining millenium house new century house and the warehouse denton manchester t/no: GM531291 the goodwill of any business. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juni 2003
    Geliefert am 27. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 16. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of windmill lane denton manchester k/a millenium house and new century house t/no GM884124. Assignment of the goodwill. The benefit of the licence or certificate. The right to recover and receive any compensation. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 25. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the undertaking, property and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 25. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The lease dated 18 september 2002; the lease dated 16 september 2002 and any lease of the whole or part of the land k/a land on the north west side of windmill lane denton.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial mortgage deed
    Erstellt am 25. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property briefly k/a land on the north west side of windmill lane denton t/no GM884124 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. By way of first fixed charge all the goodwill, the full benefit of licences, any shareholding issued and uncalled capital. By way of fixed equitable charge all estates or interest in any land. By way of assignment the rights to receive payments reserved as rent.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 26. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at windmill lane, denton, manchester t/n GM366585 (by way of legal charge). All fixtures and fittings and all fixed plant and machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sale acts). A floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment and assigns the goodwill of the business carried on at or from the property and the benefit of the licence or certificate the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Juni 1998
    Geliefert am 18. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0