FAREBROTHER GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FAREBROTHER GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03477861 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FAREBROTHER GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FAREBROTHER GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ridgway House Progress Way Windmill Lane M34 2GP Denton Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAREBROTHER GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FAREBROTHER GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FAREBROTHER GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael Smith am 14. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Arthur Edward Gee am 14. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Edwards am 14. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Martin Paul Wrigley am 14. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 155(6)b | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 9 Seiten | 155(6)a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FAREBROTHER GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIGLEY, Martin Paul | Sekretär | Ridgway House Progress Way Windmill Lane M34 2GP Denton Manchester | British | 114395980001 | ||||||
| EDWARDS, John | Geschäftsführer | Ridgway House Progress Way Windmill Lane M34 2GP Denton Manchester | England | British | 60296400001 | |||||
| GEE, Arthur Edward | Geschäftsführer | Ridgway House Progress Way Windmill Lane M34 2GP Denton Manchester | England | British | 60296640001 | |||||
| BROMLEY, Tracey Helen | Sekretär | 100 Sheffield Road SK14 2PL Hyde Cheshire | British | 49508780002 | ||||||
| STEWARD, Karen Mary | Sekretär | Windsor House 24 Werneth Road Woodley SK6 1HP Stockport Cheshire | British | 60296780002 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| BROMLEY, Tracey Helen | Geschäftsführer | 100 Sheffield Road SK14 2PL Hyde Cheshire | British | 49508780002 | ||||||
| EDWARDS, John | Geschäftsführer | 17 Moss Bank Road Swinton M27 9UJ Manchester | England | British | 60296400001 | |||||
| JOHNSON, John | Geschäftsführer | 17 Seagrave Close CW9 8UR Northwich Cheshire | England | British | 100740730001 | |||||
| PEAKE, John | Geschäftsführer | 7 Orrishmere Road SK8 5HP Cheadle Hulme Cheshire | British | 74261470001 | ||||||
| SMITH, Martin Philip | Geschäftsführer | 3 The Circuit Cheadle Hulme Cheadle SK3 9RN Stockport Cheshire | British | 87763320001 | ||||||
| SMITH, Michael | Geschäftsführer | Ridgway House Progress Way Windmill Lane M34 2GP Denton Manchester | England | British | 114796520004 | |||||
| STEWARD, John | Geschäftsführer | Windsor House 24 Werneth Road Woodley SK6 1HP Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 55224920003 | |||||
| STEWARD, Karen Mary | Geschäftsführer | Windsor House 24 Werneth Road Woodley SK6 1HP Stockport Cheshire | British | 60296780002 | ||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Hat FAREBROTHER GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment of rental income | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All payments as rent under the leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Commercial mortgage deed | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land adjoining millenium house new century house and the warehouse denton manchester t/no: GM531291 the goodwill of any business. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Juni 2003 Geliefert am 27. Juni 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Jan. 2003 Geliefert am 16. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of windmill lane denton manchester k/a millenium house and new century house t/no GM884124. Assignment of the goodwill. The benefit of the licence or certificate. The right to recover and receive any compensation. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 25. Sept. 2002 Geliefert am 27. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking, property and assets whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rental income | Erstellt am 25. Sept. 2002 Geliefert am 27. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The lease dated 18 september 2002; the lease dated 16 september 2002 and any lease of the whole or part of the land k/a land on the north west side of windmill lane denton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Commercial mortgage deed | Erstellt am 25. Sept. 2002 Geliefert am 27. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property briefly k/a land on the north west side of windmill lane denton t/no GM884124 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. By way of first fixed charge all the goodwill, the full benefit of licences, any shareholding issued and uncalled capital. By way of fixed equitable charge all estates or interest in any land. By way of assignment the rights to receive payments reserved as rent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 26. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at windmill lane, denton, manchester t/n GM366585 (by way of legal charge). All fixtures and fittings and all fixed plant and machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sale acts). A floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment and assigns the goodwill of the business carried on at or from the property and the benefit of the licence or certificate the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Juni 1998 Geliefert am 18. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0