TI MAGAZINES (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TI MAGAZINES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03483202 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IPC MAGAZINES (UK) LIMITED | 03. Feb. 1998 | 03. Feb. 1998 |
| EXCESSTOP LIMITED | 18. Dez. 1997 | 18. Dez. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. März 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. März 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Feb. 2018
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Juni 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England zum 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR am 20. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lauren Ezrol Klein als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcus Alvin Rich als Geschäftsführer am 13. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John May als Geschäftsführer am 13. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Joseph Henry Ceryanec als Direktor am 15. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Stanley Zieser als Direktor am 15. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susana D'emic als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Change of details for Time Uk Publishing Holdings Limited as a person with significant control on 04. Juni 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Notification of Time Inc. as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Geschäftsführer | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Geschäftsführer | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 217687580001 | |||||
| ALEY, William Robert | Sekretär | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| GORE, John Francis | Sekretär | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Sekretär | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| LINDEN, Brian Andrew | Sekretär | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | British | 36233000002 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Sekretär | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Sekretär | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Sekretär | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALEY, William Robert | Geschäftsführer | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Geschäftsführer | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Geschäftsführer | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Geschäftsführer | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Geschäftsführer | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Geschäftsführer | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVISON, Guy Bryce | Geschäftsführer | 128 Kensington Park Road W1 2EP London | British | 48717030002 | ||||||
| EVANS, Richard John | Geschäftsführer | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Geschäftsführer | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Geschäftsführer | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Geschäftsführer | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| MAIR, Denise Margaret | Geschäftsführer | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Geschäftsführer | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Geschäftsführer | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MUNTON, Richard James | Geschäftsführer | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | 11882410003 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Geschäftsführer | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Geschäftsführer | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Uk Publishing Holdings Limited | 04. Juni 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06. Apr. 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TI MAGAZINES (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1999 Geliefert am 02. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Erstellt am 12. Okt. 1998 Geliefert am 15. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0