WHITTLEBURY HALL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWHITTLEBURY HALL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03486156
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    • (5510) /

    Wo befindet sich WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    ZOLFO COOPER
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MACEPARK (WHITTLEBURY) LIMITED24. Dez. 199724. Dez. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 27. März 2017

    23 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Sept. 2016

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2016

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2016

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2015

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2015

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2014

    28 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2014

    19 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2013

    19 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2012

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. März 2012

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    26 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    26 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    11 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 16 the Havens Ransomes Europark Ipswich Suffolk IP3 9SJ United Kingdom* am 23. Sept. 2011

    3 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Deer Park Lodge Mannings Lane Woolverstone Ipswich Suffolk IP9 1AP* am 17. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 29. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von WHITTLEBURY HALL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROCKALL, Gillian May
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    Sekretär
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    British109258290001
    ROCKALL, Michael John
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish109258280001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BYSOUTH KEMP, Lynne Susan
    Scalford Hall
    Melton Road, Scalford
    LE14 4UB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Scalford Hall
    Melton Road, Scalford
    LE14 4UB Melton Mowbray
    Leicestershire
    British68004710001
    ROCKALL, Gillian May
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish109258290001
    ROCKALL, Michael John
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Deer Park Lodge
    Mannings Lane, Woolverstone
    IP9 1AP Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish109258280001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat WHITTLEBURY HALL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed
    Erstellt am 06. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from macepark limited and the company and any group member to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land being whittlebury hall, whittlebury, northamptonshire t/no. NN203534 including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant equipment and machinery thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 23. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 23. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H whittlebury hall hotel whittlebury northamptonshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 28. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Okt. 2004
    Geliefert am 25. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Okt. 2004
    Geliefert am 25. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a whittlebury hall,whittlebury t/no NN203534. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 2004
    Geliefert am 26. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being whittlebury hall whittlebury northamptonshire t/no NN203534. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 29. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Linden cottage, 12 high street, whittlebury, towcester, northants.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Jan. 2000
    Geliefert am 17. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or macepark limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Sept. 1999
    Geliefert am 01. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as whittlebury hall, whittlebury, northhamptonshire t/no: NN203534.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 27. Aug. 1999
    Geliefert am 08. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 17 august 1999
    Kurze Angaben
    All that l/h land being whittlebury hall,whittlebury,northamptonshire t/no NN203534.together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 1999
    Geliefert am 07. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due by the company and macepark limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company of macepark limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargees on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies deposited with the trustee on the terms under the deed together with floating charge the whole of the company's property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future including the uncalled share capital under the terms of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Lenders)
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 1998
    Geliefert am 01. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at west park whittlebury northamptonshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1998Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 28. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WHITTLEBURY HALL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Sept. 2011Beginn der Verwaltung
    27. März 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Kevin James Coates
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Mark Nicholas Cropper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0