PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED

PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03486675
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    • (7310) /

    Wo befindet sich PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PHOQUS PHARMACEUTICALS LIMITED27. Nov. 200227. Nov. 2002
    PHOQUS LIMITED29. Dez. 199729. Dez. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Feb. 2010

    6 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Jan. 2009

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    11 Seiten2.34B

    Vorschlag des Verwalters

    12 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    23 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    20 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    10 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed phoqus pharmaceuticals LIMITED\certificate issued on 18/09/07
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    20 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish70796290001
    LEATHERS, David Frederick James
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    Geschäftsführer
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    EnglandBritish84070000003
    MASON, Richard Colin St Helier, Dr
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    British122520900001
    MOSES, Edwin, Dr
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    British78748090004
    BRACE, Jacqueline Anne
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    Sekretär
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    British56818020001
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    Sekretär
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    British70796290001
    SMITH, Suzanne Elaine
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    Sekretär
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    British119288360001
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    ARMSTRONG, Frank Murdoch, Dr
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    British79589620003
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    American34371910001
    BLAKER, Graham Joseph, Dr
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish110270002
    BLANEY, Terence William Daniel
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    United KingdomBritish8680200001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CLOSE, Jon
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    Geschäftsführer
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    British78001370001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    MCLELLAND, Michael Bruce
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    Geschäftsführer
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    American63138450001
    MOTZER, William Raymond
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    Geschäftsführer
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    American17570280001
    SEAGER, Harry, Dr
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    British63260950001
    STANIFORTH, John Nicholas
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    British116945380001
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    Hat PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    10 kings hill avenue kings hill west mal. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Oxford Finance Corporation
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. März 2007
    Geliefert am 29. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Deposit balance and all amount standing to the credit of an interest bearing account.
    Berechtigte Personen
    • Kings Hill Trustee No 1 Limited and Kings Hill Trustee No 2 Limited
    Transaktionen
    • 29. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rent deposit
    Erstellt am 09. Dez. 2004
    Geliefert am 14. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held.
    Berechtigte Personen
    • Liberty Property Limited Partnership
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 23. Juli 2004
    Geliefert am 10. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from either obligor or both of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right, title and interest in and to each machine and all related rights relating to each machine but excluding any intellectual property in the design or operation of the machines. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cardinal Health U.K. 416 Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 26. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Gatx European Technology Ventures
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of rent deposit
    Erstellt am 09. Aug. 2002
    Geliefert am 14. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held opened in the name of liberty property limited partnership.
    Berechtigte Personen
    • Liberty Property Limited Partnership
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rent deposit supplemental to a lease
    Erstellt am 04. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Rouse Kent (Central) Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2001
    Geliefert am 17. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due owing or incurred by the company (whether as principal or surety) to the security trustee or any of the lenders pursuant to the terms of the investment agreement as amended from time to time dated 29/01/01
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2001
    Geliefert am 07. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the investment agreement dated 30 january 2001 ("the investment agreement") and/or the debenture (other than a dividend on any shares)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC ("the Security Trustee") (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Lenders)
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 2000
    Geliefert am 28. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Gatx European Technology Ventures
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 06. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Juli 2008Beginn der Verwaltung
    23. Feb. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    23. Feb. 2009Beginn der Liquidation
    15. Juni 2010Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0