OLD FORD HOUSING ASSOCIATION
Überblick
| Unternehmensname | OLD FORD HOUSING ASSOCIATION |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 03487210 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Two Pancras Square King's Cross N1C 4AG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b and z convert to rs | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Clare Miller als Sekretär am 29. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Pearce als Geschäftsführer am 19. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angela Marie Drum als Sekretär am 29. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 58 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Charles Trevor Fowler als Direktor am 25. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Duncan Shrubsole als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rolf Wojtanowski als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Angela Marie Drum als Sekretär am 01. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Upton als Sekretär am 31. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2015 ohne Mitgliederliste | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rolf Wojtanowski als Direktor am 11. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Pearce am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jacqueline Harris als Direktor am 10. Feb. 2010 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Marc Francis am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jennifer Ann Dearing am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Armstrong als Geschäftsführer am 22. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Deborah Upton am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 47 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Circle House 1-3 Highbury Station Road London N1 1SE zum Two Pancras Square King's Cross London N1C 4AG am 19. Feb. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2014 ohne Mitgliederliste | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Melvyn Edward Jacobs Obe als Direktor am 23. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 46 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLER, Clare | Sekretär | More London Place SE1 2DA London Level 6, 6 More London Place England | 221705990001 | |||||||
| DEARING, Jennifer Ann | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | United Kingdom | English | 137054520001 | |||||
| FOWLER, Simon Charles Trevor | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | England | British | 162070440001 | |||||
| FRANCIS, Marc | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | England | British | 125867050002 | |||||
| HARRIS, Jacqueline | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | England | British | 204256390001 | |||||
| JACOBS, Stephen Melvyn Edward | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | United Kingdom | British | 55934860002 | |||||
| SHRUBSOLE, Duncan Owen | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | England | British | 150091430004 | |||||
| WOJTANOWSKI, Rolf | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | England | German | 204256400001 | |||||
| CARPENTER, Gillian Marie | Sekretär | 23 Sedgwick Road Leyton E10 6QR London | British | 18058600001 | ||||||
| DRUM, Angela Marie | Sekretär | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | 209652440001 | |||||||
| FIRMAN, Angela June | Sekretär | 1-3 Highbury Station Road N1 1SE London Circle House United Kingdom | British | 139160540001 | ||||||
| SEMPLE, Kirsty | Sekretär | 16 Anglesea Road CO7 9JR Wivenhoe Essex | British | 119026250001 | ||||||
| UPTON, Deborah | Sekretär | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | British | 170479580001 | ||||||
| WYLES, Marianne Clare | Sekretär | 3 Park Lane EN10 7NG Broxbourne Hertfordshire | British | 51255500001 | ||||||
| ARMSTRONG, Michael John | Geschäftsführer | Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Two | United Kingdom | British | 133526160001 | |||||
| BERGIN, Deanne Cecile | Geschäftsführer | 24 Waterlow Court Heath Close NW11 7DT London | British | 46391910001 | ||||||
| BOLTON, Lucinda Carol | Geschäftsführer | 33 St Maur Road SW6 4DR London | British | 6166170001 | ||||||
| BOON, Debbie Jane | Geschäftsführer | 1-3 Highbury Station Road N1 1SE London Circle House | United Kingdom | British | 175447620001 | |||||
| BRADBURY, Patricia Anne | Geschäftsführer | 34 Riversdale Road N5 2JT London | British | 62198080001 | ||||||
| BUTCHER, David Martin | Geschäftsführer | 2 Hollybush Close Snaresbrook E11 1PZ London | England | British | 91116680001 | |||||
| CHOWDHURY, Shabbir Ahmed | Geschäftsführer | Mostyn Grove E3 2GT London 15 | United Kingdom | British | 127989930001 | |||||
| CLARK, Mary Bridget | Geschäftsführer | 4 Morville Street E3 2DG London | British | 57774230002 | ||||||
| DOBSON, Beverly | Geschäftsführer | 24 Buckingham Road E18 2NJ South Woodford London | England | British | 90754970001 | |||||
| EDDY, Colin Gonzalves | Geschäftsführer | 25a Stepney Green Stepney Green E1 3JX London | England | Trinidadian | 101116410001 | |||||
| EDDY, Colin | Geschäftsführer | 15 Deans Lane HA8 9HX Edgware Middlesex | Citizen Of Trinidadand Tobago | 79901510001 | ||||||
| GRAHAM, Herbert | Geschäftsführer | 45 Park Meadow AL9 5HB Hatfield Hertfordshire | British | 29180760001 | ||||||
| HARRIS, Jacqueline | Geschäftsführer | 3 Springwood Close Morville Street E3 2GE London | England | British | 204256390001 | |||||
| HOODLESS, Donald | Geschäftsführer | Flat 10 Eclipse Building 26 Laycock Street N1 1AH London | England | British | 95406030001 | |||||
| JACOTINE, Clive Ivan | Geschäftsführer | 54 Arbery Road E3 5DD London | England | British | 53064560001 | |||||
| LUCAS, Ann Patricia | Geschäftsführer | 14 Sextant Avenue Saunders Ness Road E14 9DX London | United Kingdom | British | 57774190001 | |||||
| LUDLOW, Janet | Geschäftsführer | 48 Lichfield Road E3 5AT London | England | British | 21935580001 | |||||
| MABEY, Robin Charles | Geschäftsführer | 42 Highbury Place N5 1QL London | British | 48398720001 | ||||||
| MATHURIN, Chantel | Geschäftsführer | Elsa Street E1 0NY London 8 | United Kingdom | British | 140834120001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Bonnie | Geschäftsführer | 4 Ermine House Bow E3 2QQ London | British | 104330350001 | ||||||
| MILLER, Ray | Geschäftsführer | 311 Old Ford Road E3 5PR London | British | 88159610001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 22. Dez. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat OLD FORD HOUSING ASSOCIATION Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Erstellt am 28. Sept. 2010 Geliefert am 07. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor with full title guarantee as security for the paymet of all secured obligations charged in favour of the security trustee by way of first fixed charge all benefits claims and returns of permiums in respect of any insurance see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An account charge | Erstellt am 17. Feb. 2010 Geliefert am 05. März 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged account and the credit balance from time to time of the charged account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 10. Sept. 2008 Geliefert am 18. Sept. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as a trustee for the other secured beneficiaries) or to any of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and any part of any estate or interest in the property being 20, 24, 30, 34, 38, 46 and 48 jodrell road; 1-76 (inc) waverton house, jodell road london; 1-76 (inc) winford house; 1-56 (inc) ollerton green; 1-62 (inc) elton house, 1-147 (odd) and 2-36 (even) candy street and 1-40 (inc) locton green, ruston street, london (formerly known as land and buildings being known as the locton estate london t/no EGL530242. 89 cadogan terrace t/no 149181. for details of further properties charged please refer to form 395. see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Dez. 2007 Geliefert am 20. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north west side of hawthorn avenue london t/no EGL446969; 25 usher road bow NGL441623; 23 usher road bow t/no EGL213595 (for further details of properties charged please refer to form 395) and all buildings, fixtures, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 12. Okt. 2007 Geliefert am 18. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge the whole of the chargors undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 08. Okt. 2007 Geliefert am 13. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 08. Okt. 2007 Geliefert am 13. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies du or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A fixed charge | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 13. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licencesand all income and claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An account charge | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 13. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All moneys from time to time standing to the credit of the sinking fund and the facility account and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 04. Apr. 2005 Geliefert am 22. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whole of the chargor's undertaking and assets,present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0