OLD FORD HOUSING ASSOCIATION

OLD FORD HOUSING ASSOCIATION

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOLD FORD HOUSING ASSOCIATION
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 03487210
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Two Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verschiedenes

    Forms b and z convert to rs
    2 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to rs 19/09/2016
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Clare Miller als Sekretär am 29. Nov. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Pearce als Geschäftsführer am 19. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Angela Marie Drum als Sekretär am 29. Nov. 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    58 SeitenAA

    Ernennung von Mr Simon Charles Trevor Fowler als Direktor am 25. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Duncan Shrubsole als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Rolf Wojtanowski als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Angela Marie Drum als Sekretär am 01. Feb. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Deborah Upton als Sekretär am 31. Jan. 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2015 ohne Mitgliederliste

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Rolf Wojtanowski als Direktor am 11. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Pearce am 02. Feb. 2015

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mrs Jacqueline Harris als Direktor am 10. Feb. 2010

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Marc Francis am 02. Feb. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Jennifer Ann Dearing am 02. Feb. 2015

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Michael John Armstrong als Geschäftsführer am 22. März 2015

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Sekretärs für Deborah Upton am 02. Feb. 2015

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    47 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Circle House 1-3 Highbury Station Road London N1 1SE zum Two Pancras Square King's Cross London N1C 4AG am 19. Feb. 2015

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Dez. 2014 ohne Mitgliederliste

    7 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Stephen Melvyn Edward Jacobs Obe als Direktor am 23. Sept. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    46 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MILLER, Clare
    More London Place
    SE1 2DA London
    Level 6, 6 More London Place
    England
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2DA London
    Level 6, 6 More London Place
    England
    221705990001
    DEARING, Jennifer Ann
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomEnglish137054520001
    FOWLER, Simon Charles Trevor
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish162070440001
    FRANCIS, Marc
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish125867050002
    HARRIS, Jacqueline
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish204256390001
    JACOBS, Stephen Melvyn Edward
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomBritish55934860002
    SHRUBSOLE, Duncan Owen
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish150091430004
    WOJTANOWSKI, Rolf
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandGerman204256400001
    CARPENTER, Gillian Marie
    23 Sedgwick Road
    Leyton
    E10 6QR London
    Sekretär
    23 Sedgwick Road
    Leyton
    E10 6QR London
    British18058600001
    DRUM, Angela Marie
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Sekretär
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    209652440001
    FIRMAN, Angela June
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United Kingdom
    Sekretär
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United Kingdom
    British139160540001
    SEMPLE, Kirsty
    16 Anglesea Road
    CO7 9JR Wivenhoe
    Essex
    Sekretär
    16 Anglesea Road
    CO7 9JR Wivenhoe
    Essex
    British119026250001
    UPTON, Deborah
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Sekretär
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    British170479580001
    WYLES, Marianne Clare
    3 Park Lane
    EN10 7NG Broxbourne
    Hertfordshire
    Sekretär
    3 Park Lane
    EN10 7NG Broxbourne
    Hertfordshire
    British51255500001
    ARMSTRONG, Michael John
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomBritish133526160001
    BERGIN, Deanne Cecile
    24 Waterlow Court
    Heath Close
    NW11 7DT London
    Geschäftsführer
    24 Waterlow Court
    Heath Close
    NW11 7DT London
    British46391910001
    BOLTON, Lucinda Carol
    33 St Maur Road
    SW6 4DR London
    Geschäftsführer
    33 St Maur Road
    SW6 4DR London
    British6166170001
    BOON, Debbie Jane
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    Geschäftsführer
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United KingdomBritish175447620001
    BRADBURY, Patricia Anne
    34 Riversdale Road
    N5 2JT London
    Geschäftsführer
    34 Riversdale Road
    N5 2JT London
    British62198080001
    BUTCHER, David Martin
    2 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    EnglandBritish91116680001
    CHOWDHURY, Shabbir Ahmed
    Mostyn Grove
    E3 2GT London
    15
    Geschäftsführer
    Mostyn Grove
    E3 2GT London
    15
    United KingdomBritish127989930001
    CLARK, Mary Bridget
    4 Morville Street
    E3 2DG London
    Geschäftsführer
    4 Morville Street
    E3 2DG London
    British57774230002
    DOBSON, Beverly
    24 Buckingham Road
    E18 2NJ South Woodford
    London
    Geschäftsführer
    24 Buckingham Road
    E18 2NJ South Woodford
    London
    EnglandBritish90754970001
    EDDY, Colin Gonzalves
    25a Stepney Green
    Stepney Green
    E1 3JX London
    Geschäftsführer
    25a Stepney Green
    Stepney Green
    E1 3JX London
    EnglandTrinidadian101116410001
    EDDY, Colin
    15 Deans Lane
    HA8 9HX Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    15 Deans Lane
    HA8 9HX Edgware
    Middlesex
    Citizen Of Trinidadand Tobago79901510001
    GRAHAM, Herbert
    45 Park Meadow
    AL9 5HB Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    45 Park Meadow
    AL9 5HB Hatfield
    Hertfordshire
    British29180760001
    HARRIS, Jacqueline
    3 Springwood Close
    Morville Street
    E3 2GE London
    Geschäftsführer
    3 Springwood Close
    Morville Street
    E3 2GE London
    EnglandBritish204256390001
    HOODLESS, Donald
    Flat 10 Eclipse Building
    26 Laycock Street
    N1 1AH London
    Geschäftsführer
    Flat 10 Eclipse Building
    26 Laycock Street
    N1 1AH London
    EnglandBritish95406030001
    JACOTINE, Clive Ivan
    54 Arbery Road
    E3 5DD London
    Geschäftsführer
    54 Arbery Road
    E3 5DD London
    EnglandBritish53064560001
    LUCAS, Ann Patricia
    14 Sextant Avenue
    Saunders Ness Road
    E14 9DX London
    Geschäftsführer
    14 Sextant Avenue
    Saunders Ness Road
    E14 9DX London
    United KingdomBritish57774190001
    LUDLOW, Janet
    48 Lichfield Road
    E3 5AT London
    Geschäftsführer
    48 Lichfield Road
    E3 5AT London
    EnglandBritish21935580001
    MABEY, Robin Charles
    42 Highbury Place
    N5 1QL London
    Geschäftsführer
    42 Highbury Place
    N5 1QL London
    British48398720001
    MATHURIN, Chantel
    Elsa Street
    E1 0NY London
    8
    Geschäftsführer
    Elsa Street
    E1 0NY London
    8
    United KingdomBritish140834120001
    MCLAUGHLIN, Bonnie
    4 Ermine House
    Bow
    E3 2QQ London
    Geschäftsführer
    4 Ermine House
    Bow
    E3 2QQ London
    British104330350001
    MILLER, Ray
    311 Old Ford Road
    E3 5PR London
    Geschäftsführer
    311 Old Ford Road
    E3 5PR London
    British88159610001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    22. Dez. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat OLD FORD HOUSING ASSOCIATION Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed charge
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 07. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor with full title guarantee as security for the paymet of all secured obligations charged in favour of the security trustee by way of first fixed charge all benefits claims and returns of permiums in respect of any insurance see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    An account charge
    Erstellt am 17. Feb. 2010
    Geliefert am 05. März 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged account and the credit balance from time to time of the charged account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Circle Anglia Social Housing PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Fixed charge
    Erstellt am 10. Sept. 2008
    Geliefert am 18. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as a trustee for the other secured beneficiaries) or to any of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and any part of any estate or interest in the property being 20, 24, 30, 34, 38, 46 and 48 jodrell road; 1-76 (inc) waverton house, jodell road london; 1-76 (inc) winford house; 1-56 (inc) ollerton green; 1-62 (inc) elton house, 1-147 (odd) and 2-36 (even) candy street and 1-40 (inc) locton green, ruston street, london (formerly known as land and buildings being known as the locton estate london t/no EGL530242. 89 cadogan terrace t/no 149181. for details of further properties charged please refer to form 395. see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Dez. 2007
    Geliefert am 20. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north west side of hawthorn avenue london t/no EGL446969; 25 usher road bow NGL441623; 23 usher road bow t/no EGL213595 (for further details of properties charged please refer to form 395) and all buildings, fixtures, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 18. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge the whole of the chargors undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Trustee for the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 08. Okt. 2007
    Geliefert am 13. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 08. Okt. 2007
    Geliefert am 13. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 16. März 2006
    Geliefert am 22. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies du or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A fixed charge
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 13. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licencesand all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 13. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An account charge
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 13. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All moneys from time to time standing to the credit of the sinking fund and the facility account and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent
    Transaktionen
    • 13. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 04. Apr. 2005
    Geliefert am 22. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The whole of the chargor's undertaking and assets,present and future.
    Berechtigte Personen
    • Circle Thirty Three Housing Trust Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0