MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03488633 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MEDOMSLEY SECURE TRAINING SERVICES LIMITED | 13. März 1998 | 13. März 1998 |
| ALNERY NO. 1734 LIMITED | 05. Jan. 1998 | 05. Jan. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Peter Ashbrook am 01. Mai 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 01. Juni 2016 | 20 Seiten | RP04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Feb. 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr John Ivor Cavill als Direktor am 25. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Biif Corporate Services Limited als Geschäftsführer am 25. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , C/O Dundas & Wilson, Northwest Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ zum Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Peter Ashbrook am 01. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Peter Ashbrook als Direktor am 25. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard David Hoile als Geschäftsführer am 25. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , C/O Dundas & Wilson, North West Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ am 27. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Sekretär | Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| ASHBROOK, Philip Peter | Geschäftsführer | 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 121252960004 | |||||||||
| BALDOCK, Graham | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | United Kingdom | British | 49519600001 | |||||||||
| CAVILL, John Ivor | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | England | British | 152521640008 | |||||||||
| BESWICK, Nigel Lloyd | Sekretär | 44 Brantwood Road Herne Hill SE24 0DJ London | British | 56835390001 | ||||||||||
| COOKE, David John | Sekretär | 31 Foxborough Swallowfield RG7 1RW Reading Berkshire | British | 83213800001 | ||||||||||
| MOORE, William Edmond | Sekretär | 35 Black Acre Close HP7 9EW Amersham Buckinghamshire | British | 114630630002 | ||||||||||
| TODD, Francesca Anne | Sekretär | 26 Glebe Road SM2 7NT Cheam Surrey | British | 72249980001 | ||||||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
| BAILEY, Carol Elaine | Geschäftsführer | Apt 24 Claremont Lodge 15 The Downs SW20 8UA London | British | 93650840001 | ||||||||||
| BAILEY, Carol Elaine | Geschäftsführer | 193 Cottenham Park Road SW20 0SY London | England | British | 9905530001 | |||||||||
| BESWICK, Nigel Lloyd | Geschäftsführer | 44 Brantwood Road Herne Hill SE24 0DJ London | United Kingdom | British | 56835390001 | |||||||||
| CALABRESE, Wayne Howard | Geschäftsführer | 193 Ocean Key Way 33477 Jupiter Florida Usa | United States | American | 30780670003 | |||||||||
| CARTER, James Duncan | Geschäftsführer | The Slopes Charterhouse Road GU7 2AW Godalming Surrey | British | 93908800001 | ||||||||||
| CORNWELL, Anthony Bruce | Geschäftsführer | The Cottage 134 London Road GU19 5BZ Bagshot Surrey | United Kingdom | British | 3471920001 | |||||||||
| CRAWSHAW, Andrew Julian | Geschäftsführer | 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9UY Hook Serco House Hampshire | England | British | 130322170001 | |||||||||
| EDWARDS, Philip John | Geschäftsführer | 430 Yorktown Road GU47 0PR Sandhurst Berkshire | British | 87032350001 | ||||||||||
| FUTCHER, William Frank | Geschäftsführer | 1 Beech Park HP6 6PY Amersham Buckinghamshire | British | 51346890001 | ||||||||||
| HAGA, Thomas Justin | Geschäftsführer | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London North West Wing Bush House | United Kingdom | British | 111282640001 | |||||||||
| HAYWARD, Neil | Geschäftsführer | 21 Gibbon Road KT2 6AD Kingston Upon Thames Surrey | British | 144924760001 | ||||||||||
| HILL, Gavin | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | 84457250005 | |||||||||
| HOILE, Richard David | Geschäftsführer | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London Northwest Wing Bush House United Kingdom | United Kingdom | British | 137848430002 | |||||||||
| JEFFERY, John Daniel Michael | Geschäftsführer | Fairpark House 18 Green Lane KT11 2NN Cobham Surrey | British | 93851850002 | ||||||||||
| KEENS, Donald Herbert | Geschäftsführer | 7807 Ironhorse Boulevard West Palm Beach 33412 Usa | British | 70256340003 | ||||||||||
| LEACH, Guy William | Geschäftsführer | Apartment D162 Parliment View Apartments 1 Albert Embankment SE1 7XQ London | British | 70877660003 | ||||||||||
| LEWIS, Kevin Tony | Geschäftsführer | 36 Woodbury Road St Ives New South Wales 2075 Australia | Australian | 86468730001 | ||||||||||
| LEWIS, Kevin Tony | Geschäftsführer | Boanti House Swallowfield Street RG7 1QX Swallowfield Berkshire | Australian | 52036330001 | ||||||||||
| MCDONAGH, John | Geschäftsführer | 30 St Botolph's Road Sevenoaks TN13 3AG Kent | British | 116580030002 | ||||||||||
| MCNAUGHT, William Wright | Geschäftsführer | 14 Church Road East GU14 6QJ Farnborough Hampshire | British | 52531510002 | ||||||||||
| MEAD, Mark William | Geschäftsführer | 28 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 151850410001 | |||||||||
| MIDDLETON, Nigel Wythen | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 156912990001 | |||||||||
| REICHERTER, Matthias Alexander | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | German | 138502740001 | |||||||||
| RIALL, Thomas Richard Phineas | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | 76434190002 | |||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Geschäftsführer | Central Building 3 Matthew Parker Street SW1H 9NE London Apartment 42, | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| SMITH, John | Geschäftsführer | 4 Longwater Lane RG40 4NZ Finchampstead Berkshire | British | 95897660001 |
Hat MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Erstellt am 02. Dez. 2006 Geliefert am 07. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from pcfl to the security trustee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the company's right,title and interest,present and future,in.under and to the relevant contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and counter-indemnity | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the senior charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and counter-indemnity | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the subordinated charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A subordinated fixed and floating charge | Erstellt am 12. Nov. 1998 Geliefert am 27. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under each or any of the financing agreements | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of fixed charge | Erstellt am 12. Nov. 1998 Geliefert am 20. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement of even date ("the dcmf contract") | |
Kurze Angaben All the companys right title and interest in and to the equipment (as defined therein). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. Nov. 1998 Geliefert am 25. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) under each or any of the financing agreements | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0