NPS (UK5) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NPS (UK5) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03495019 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NPS (UK5) LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich NPS (UK5) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NPS (UK5) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED | 28. Nov. 2008 | 28. Nov. 2008 |
ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED | 02. Feb. 2000 | 02. Feb. 2000 |
IMASYS LIMITED | 16. Feb. 1998 | 16. Feb. 1998 |
IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED | 14. Jan. 1998 | 14. Jan. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NPS (UK5) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NPS (UK5) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Juli 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2019 bis 31. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Noble als Geschäftsführer am 06. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Callaghan am 06. Aug. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ian Michael Noble als Direktor am 06. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Coll als Geschäftsführer am 06. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen James Callaghan als Direktor am 10. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Meaden als Geschäftsführer am 10. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION |
Wer sind die Geschäftsführer von NPS (UK5) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
CALLAGHAN, Stephen James | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 201347710052 | ||||||||
COUTTS, Cheryl Jane | Sekretär | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||||||
COX, Melanie Rachel | Sekretär | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||||||
HEMMING, Vivienne Ruth | Sekretär | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||||||
HUMPHREY, Christopher John | Sekretär | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||||||
RICHARDSON, John David | Sekretär | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire | British | 128558470001 | ||||||||||
SADLER, John Michael | Sekretär | 14 Highlands Close SL9 0DR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78431540001 | ||||||||||
SCHENCK, Daniel William | Sekretär | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
SHAH, Bijal | Sekretär | 24 Dorset Mews Finchley N3 2BN London | British | 116421860001 | ||||||||||
TIDSALL, David Peter Charles | Sekretär | 50 Anglesey Avenue Cove GU14 8SQ Farnborough Hampshire | British | 3854790001 | ||||||||||
WENMAN, Nicholas Edward | Sekretär | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | Company Director | 14373460003 | |||||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
AL-SALEH, Adel Bedry | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | Director | 165900220001 | ||||||||
BASS, Neil Anthony | Geschäftsführer | 31 Archery Fields RG29 1AE Odiham Hampshire | England | British | Director | 70199330002 | ||||||||
BEATON, Richard L'Estrange | Geschäftsführer | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | Company Director | 97291590001 | ||||||||
BODHA, James Sanjay | Geschäftsführer | Rook How 22 Elm Tree Road WA13 0NB Lymm Cheshire | England | British | Director | 93657140001 | ||||||||
COLL, Andrew | Geschäftsführer | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 237260100001 | ||||||||
GIBSON, John Leonard | Geschäftsführer | Ivydene Delly End OX29 9XD Hailey Oxfordshire | British | Director | 104554430001 | |||||||||
HUMPHREY, Christopher John | Geschäftsführer | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | United Kingdom | British | Accountant | 32877720003 | ||||||||
HUNT, Simon Anthony | Geschäftsführer | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | Director Chartered Accountant | 118771650001 | |||||||||
KINGSWOOD, Michael | Geschäftsführer | Holm Farm Catesby End Hellidon NN11 6GB Daventry Northamptonshire | British | Managing Director | 123863990001 | |||||||||
MARRISON, Michael Anthony | Geschäftsführer | 10 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | England | British | Company Director | 67938980003 | ||||||||
MCCANN, James | Geschäftsführer | 32 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | British | Chartered Management Accountan | 69923680001 | |||||||||
MEADEN, David John | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 193740420001 | ||||||||
NOBLE, Ian Michael | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Director | 199843940001 | ||||||||
ROWLEY, Stephen Paul, Mr. | Geschäftsführer | Hadleigh 16 Sandown Road KT10 9TU Esher Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 93738770001 | ||||||||
SLOGGETT, David Raymond, Dr | Geschäftsführer | 12 Mcnaughton Close GU14 0PX Farnborough Hampshire | British | Director | 34112730001 | |||||||||
STIER, John Robert | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 78901530003 | ||||||||
STONE, Christopher Michael Renwick | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 66955690003 | ||||||||
TAIT, Ian | Geschäftsführer | Field House Evesham Road WR10 2QR Fladbury Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 76976490001 | ||||||||
TYRRELL, Simon Robert Edgar | Geschäftsführer | Larks 15 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | England | British | Company Director | 77284710002 | ||||||||
WENMAN, Nicholas Edward | Geschäftsführer | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | Company Director | 14373460003 | |||||||||
WOOTTON BEARD, Timothy | Geschäftsführer | Catkins Westhill Road North, South Wonston SO21 3HJ Winchester Hampshire | British | Company Director | 93274500001 | |||||||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NPS (UK5) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nps (Uk2) Limited | 06. Apr. 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat NPS (UK5) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession | Erstellt am 27. Feb. 2009 Geliefert am 09. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 16. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 15. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 28. Nov. 2006 Geliefert am 30. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002 | Erstellt am 28. Feb. 2006 Geliefert am 02. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of deposit | Erstellt am 18. Dez. 2003 Geliefert am 19. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus letter of set-off | Erstellt am 09. Dez. 2002 Geliefert am 13. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 10. Mai 2002 Geliefert am 24. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 08. Dez. 2000 Geliefert am 21. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise) | |
Kurze Angaben The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995) | Erstellt am 09. Apr. 1999 Geliefert am 21. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 10. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NPS (UK5) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0