NPS (UK5) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNPS (UK5) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03495019
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NPS (UK5) LIMITED?

    • Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich NPS (UK5) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NPS (UK5) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED28. Nov. 200828. Nov. 2008
    ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED02. Feb. 200002. Feb. 2000
    IMASYS LIMITED16. Feb. 199816. Feb. 1998
    IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED14. Jan. 199814. Jan. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NPS (UK5) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für NPS (UK5) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Juni 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018

    2 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2019 bis 31. März 2019

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Ian Michael Noble als Geschäftsführer am 06. Aug. 2018

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Callaghan am 06. Aug. 2018

    2 SeitenCH01

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    5 SeitenAA

    Ernennung von Ian Michael Noble als Direktor am 06. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Coll als Geschäftsführer am 06. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Stephen James Callaghan als Direktor am 10. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Meaden als Geschäftsführer am 10. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 61,686,134.332
    SH01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name16. Juni 2015

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Juni 2015

    RES15

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    5 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Wer sind die Geschäftsführer von NPS (UK5) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Sekretär
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Sekretär
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Sekretär
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Sekretär
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Sekretär
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Sekretär
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Sekretär
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director14373460003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritishDirector70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director97291590001
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector93657140001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    BritishDirector104554430001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Geschäftsführer
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritishAccountant32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Geschäftsführer
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    BritishDirector Chartered Accountant118771650001
    KINGSWOOD, Michael
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    BritishManaging Director123863990001
    MARRISON, Michael Anthony
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director67938980003
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    BritishChartered Management Accountan69923680001
    MEADEN, David John
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    BritishDirector34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director14373460003
    WOOTTON BEARD, Timothy
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director93274500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NPS (UK5) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06526803
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat NPS (UK5) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession
    Erstellt am 27. Feb. 2009
    Geliefert am 09. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 09. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 28. Nov. 2006
    Geliefert am 30. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 02. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 18. Dez. 2003
    Geliefert am 19. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 13. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 10. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 08. Dez. 2000
    Geliefert am 21. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Kurze Angaben
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Erstellt am 09. Apr. 1999
    Geliefert am 21. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 04. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NPS (UK5) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juni 2019Beginn der Liquidation
    02. Okt. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0