LPB REALISATIONS 2020 LIMITED

LPB REALISATIONS 2020 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLPB REALISATIONS 2020 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03496444
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    • Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LE BISTROT PIERRE LIMITED24. Mai 200524. Mai 2005
    SUNDAY AFTERNOON LIMITED21. Jan. 199821. Jan. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    26 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    26 SeitenAM10

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    105 SeitenAM16

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    25 SeitenAM10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 23. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    24 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    26 SeitenAM10

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 10. Juli 2020

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA/AM02SOC

    17 SeitenAM02

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOC

    17 SeitenAM02

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOC

    4 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    16 SeitenAM02

    Vorschlag des Verwalters

    50 SeitenAM03

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Milton Chambers 19 Milton Street Nottingham NG1 3EU zum Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Aug. 2020

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2019

    30 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Adam Benjamin Griggs als Geschäftsführer am 13. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018

    31 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BEACHAM, Robert Michael
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Sekretär
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    British59422880004
    BEACHAM, Robert Michael
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    United KingdomBritish59422880005
    WHITE, Nicholas James
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish246612570001
    WHITEHEAD, John Henry Thomas
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish56633010005
    ARGUS NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Bevollmächtigter Sekretär
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010830001
    BAKER, Frances Chloe
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    Geschäftsführer
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    United KingdomBritish136118640001
    FOWLE, Adam
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    Geschäftsführer
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    United KingdomBritish175194920001
    GRIGGS, Adam Benjamin
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237141510001
    MOSS, Ronald Allen
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    Geschäftsführer
    19 Milton Street
    NG1 3EU Nottingham
    Milton Chambers
    England
    EnglandBritish6787850003
    ARGUS NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010820001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LPB REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Beacham Whitehead Holdings Limited
    Milton Street
    NG1 3EN Nottingham
    19
    England
    06. Apr. 2016
    Milton Street
    NG1 3EN Nottingham
    19
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer03496157
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat LPB REALISATIONS 2020 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Dez. 2015
    Geliefert am 23. Dez. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The property known as unit 8, the old brewery quarter CF10 1FG registered under title number CYM606683. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (Registered in England and Wales with Number 00929027)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juli 2015
    Geliefert am 01. Aug. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    L/H property at basement ground and forst floor of 4 princess buildings bath.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 15. Juni 2015
    Geliefert am 16. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of legal mortgage all legal interest in units 1 and 5 abbey crescent, torbay road, torquay, TQ2 5HB.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Nov. 2013
    Geliefert am 07. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of legal mortgage all legal interest in 13, 15 & 17 milton street & part first floor milton chambers, nottingham, NG1 3EN. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Sept. 2013
    Geliefert am 12. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Catering unit 3, 4 and 5 and boardroom, ground floor, new cooperage, royal william yard, plymouth (land registry title no. DN632169). Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2012
    Geliefert am 17. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground and first floor, 8-10 millstone lane, leicester by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2011
    Geliefert am 13. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 2011
    Geliefert am 24. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Basement,ground and first floors the crescent hotel brook street ilkley t/no WYK931960 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2010
    Geliefert am 24. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First floor town centre house, cheltenham crescent, harrogate, north yorkshire t/no NYK287454. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 2010
    Geliefert am 23. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 8 victoria buildings london road stockton heath t/no. CH546669 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 24. Feb. 2010
    Geliefert am 04. März 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £16,890.63 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All sums secured under the terms of a rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • The Town Centre House Property Partnership
    Transaktionen
    • 04. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 19. Jan. 2009
    Geliefert am 20. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor and basement 13117 milton street nottinghamby way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 15. Jan. 2009
    Geliefert am 21. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Swans nest restaurant and bar swans nest hotel swans nest lane stratford upon avon by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 15. Jan. 2009
    Geliefert am 20. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 2 (upper land) and unit 3, 835 eccleshall rd, sheffield. By way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 13. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    28 park street, royal priors, leamington spa, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2001
    Geliefert am 31. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 1998
    Geliefert am 18. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LPB REALISATIONS 2020 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Juli 2020Beginn der Verwaltung
    20. Juli 2022Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicholas Holloway
    C/O Interpath Ltd, 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    C/O Interpath Ltd, 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0