LINK MAILING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LINK MAILING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03498476 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LINK MAILING LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich LINK MAILING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C12 Marquis Court Marquisway Team Valley NE11 0RU Gateshead |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LINK MAILING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LINK MAILING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS zum C12 Marquis Court Marquisway Team Valley Gateshead NE11 0RU am 30. Mai 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034984760010, erstellt am 19. Juli 2017 | 15 Seiten | MR01 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 034984760008 | 1 Seiten | MR05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 034984760009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kingsnorth House 1, Blenheim Way Kingstanding Birmingham B44 8LS England zum Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS am 24. Feb. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Business Services Centre 446-450 Kingstanding Road Birmingham West Midlands B44 9SA zum Kingsnorth House Blenheim Way Birmingham West Midlands B44 8LS am 24. Feb. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 034984760009 | 14 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LINK MAILING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALDSON, Deborah | Geschäftsführer | 127 Princethorpe Way CV3 2FW Coventry West Midlands | England | British | 120825780001 | |||||
| JONES, Darren Raymond | Sekretär | 16 Amersham Close CV5 9HH Coventry West Midlands | British | 94552640001 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| ACKLAND, Michael Edward | Geschäftsführer | 10a Beaudesert Lane B95 5JY Henley In Arden West Midlands | England | British | 33087270002 | |||||
| ASKEY, Wayne | Geschäftsführer | 37 Charlesworth Avenue Monks Path B90 4SE Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 31602690002 | |||||
| HOLMES, John Jeffrey | Geschäftsführer | 8 Beeston Avenue Wakes Meadow NN3 9UG Northampton Northamptonshire | British | 56459630001 | ||||||
| JONES, Darren Raymond | Geschäftsführer | Kingstanding Road B44 9SA Birmingham 446-450 West Midlands England | England | British | 94552640001 | |||||
| JONES, Darren Raymond | Geschäftsführer | 16 Amersham Close CV5 9HH Coventry West Midlands | England | British | 94552640001 | |||||
| STRINGER, Gareth Peter | Geschäftsführer | 35 Boiler House Electric Wharf CV1 4JU Coventry West Midlands | England | British | 120825740002 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LINK MAILING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mrs Deborah Donaldson | 31. Juli 2016 | Bodmin Road CV2 5DB Coventry Unit 1a Abbey Industrial Estate West Midlands England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat LINK MAILING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Juli 2017 Geliefert am 20. Juli 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2013 Geliefert am 18. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. All monies, obligations and liabilities whatsoever (whether principal, interest or otherwise) which may now or at any time in the future be due owing or incurred by link mailing limited ("the company") to the lender, whether present or future, actual or contingent whether alone, severally or jointly as principal, guarantor surety or otherwise and in whatever name or style and whether on any current or other account, or in any other manner whatsoever together with interest and including (but without limitation) all expenses so that interest shall be calculated and compounded in accordance with the usual practise of the lender from time to time as well after as before judgment.. All plant, machinery, implements, utensils, chattels, equipment and other tangible assets now or from time to time used in the business.. All of the company's other present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever, including (but without limitation) all the book and other debts of the company, and all freehold and leasehold property and all assets not subject to a fixed charge under this debenture.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Sept. 2013 Geliefert am 01. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Unit 5 binns close tile hill coventry. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2003 Geliefert am 30. Sept. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 02. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £3,256. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 10. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,407.50 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The rent deposit of £3,407.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 06. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben £3,407.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 06. Okt. 2000 Geliefert am 17. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring or discounting arrangement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge on all book debts | Erstellt am 01. Juni 1998 Geliefert am 10. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under any factoring or discounting arrangement | |
Kurze Angaben All book debts together with the benefit of all rights attached to such book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 01. Mai 1998 Geliefert am 06. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the company to the chargee under a lease dated 1 may 1998 | |
Kurze Angaben The deposit being £3407.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LINK MAILING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0