FUTURIST DEVELOPMENTS LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFUTURIST DEVELOPMENTS LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03499725
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SKELHORNE DEVELOPMENTS LIMITED27. Jan. 199827. Jan. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    11 Seiten4.72

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juni 2012

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. März 2012

    2 Seiten3.6

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Dez. 2011

    16 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. März 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Sept. 2010

    2 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von FUTURIST DEVELOPMENTS LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GASKIN, Edward Henry
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Geschäftsführer
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    United KingdomBritish138322330001
    MURPHY, Gerard Michael John
    Maryton Grange
    Allerton Road
    L18 3NU Liverpool
    The Gables
    Geschäftsführer
    Maryton Grange
    Allerton Road
    L18 3NU Liverpool
    The Gables
    EnglandBritish146848380001
    KINGSTON, Rechel, Mrs.
    Abbeystead Road
    L15 7JF Liverpool
    22,
    Sekretär
    Abbeystead Road
    L15 7JF Liverpool
    22,
    British133278790001
    SIMPSON, Mark James
    Hollybank
    The Avenue, Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    Hollybank
    The Avenue, Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    British66155760002
    WILLIAMS, Hilary Margaret
    16 Kindale Road
    Prenton
    CH43 3AT Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    16 Kindale Road
    Prenton
    CH43 3AT Birkenhead
    Merseyside
    British9966680001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    LEE, Derek David
    2 Moss Street
    L6 1HF Liverpool
    Geschäftsführer
    2 Moss Street
    L6 1HF Liverpool
    United KingdomBritish79608400002
    MURPHY, Gerard
    The Gables
    Maryton Grange Old Allerton Road
    L18 3JT Liverpool
    Geschäftsführer
    The Gables
    Maryton Grange Old Allerton Road
    L18 3JT Liverpool
    British75678420002
    SIMPSON, Mark James
    Hollybank
    The Avenue, Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hollybank
    The Avenue, Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish66155760002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat FUTURIST DEVELOPMENTS LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security assignment
    Erstellt am 18. Mai 2009
    Geliefert am 22. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its title rights and interests in the loans the proceedings of any payments claims damages and all agreements contracts undertakings guarantees and other documents under or in relation to the loans see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 22. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juni 2007
    Geliefert am 22. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,094,637.62 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    The whole property (including uncalled capital) by way of fixed and floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • GB Finance Group PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Former rmc house st mary's road.
    Berechtigte Personen
    • G B Finance Group PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 61 & 61A lime street liverpool t/n MS201429, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 822. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 822. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 8
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 59 lime street and 24 bolton street liverpool t/n MS489270, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 722. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 722. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 7
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 57 lime street liverpool t/n MS317647, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 622. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 622. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 6
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 55 lime street liverpool t/n MS3317644, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 522. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 522. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 5
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 53 lime street liverpool t/n MS303346 and MS235472, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 422. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 422. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 4
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 45 lime street liverpool t/n MS262765, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 322. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 322. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 3
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings on the west side of bolton street liverpool t/n MS59167 the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 222. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 222. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Cash deposit security deed
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit being all monies in the designated deposit account,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from new capital speke limited to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The 6,000 a ordinary shares in the share capital of the borrower, all income derived from the securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 71 & 73 lime street liverpool t/n MS313101, the gross rents, the benefit of all guarantees, insurance, goodwill all funds standing to the credit on any account, all moveable plant machinery and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Property Lending Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 122. Jan. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 122. Jan. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 71 and 73 lime street liverpool t/no MS313101. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 57 lime street liverpool t/no MS317647. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 53 lime street liverpool t/no MS303346. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 45 lime street liverpool t/no MS262765. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the west side of bolton street liverpool t/no MS59167. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 63 to 69 (odd) lime street 26 and 28 bolton street and 61 and 61A lime street liverpool t/no MS201429. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 59 lime street and 24 bolton street liverpool t/no MS489270. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 06. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    59 lime street, liverpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2004
    Geliefert am 04. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    53 lime street liverpool t/no: MS303346. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 2002
    Geliefert am 20. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    71 and 72 lime street liverpool t/n MS313101. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Hat FUTURIST DEVELOPMENTS LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    5Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    6Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    7Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    8Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Richard Jennings
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Cloister House Riverside
    New Bailey Streeet
    M3 5AG Manchester
    Hugh Lawrence Dorins
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Cloister House
    Riverside, New Bailey Street
    M3 5AG Manchester
    Andrew Vaughan
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    Receiver Manager
    Edward Symmons Llp Charles House
    148/149 Great Charles Street
    B3 3HT Birmingham
    9
    DatumTyp
    24. Juni 2011Beginn der Verwaltung
    18. Juni 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    10
    DatumTyp
    18. Juni 2012Beginn der Liquidation
    02. Okt. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Praktiker
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0