JENSTONE PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JENSTONE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03503117 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JENSTONE LIMITED | 03. Feb. 1998 | 03. Feb. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2022 bis 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2021 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte vollständige Konten mit voller Befreiung erstellt bis 31. März 2017 | 11 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Konten für ein kleines Unternehmen erstellt bis 31. März 2014 | 6 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS, Emma Sarah | Sekretär | 249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG Essex | British | 148013900001 | ||||||
| DAVIS, Emma Sarah | Geschäftsführer | 249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG Essex | United Kingdom | British | 148013900001 | |||||
| DAVIS, Lewis John | Geschäftsführer | 249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG Essex | England | British | 146476190001 | |||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JENSTONE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Lewis John Davis | 05. Jan. 2017 | 249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG Essex | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat JENSTONE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over members' interests | Erstellt am 25. März 2013 Geliefert am 30. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the cip (barrett st) LLP to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all of the chargor's right title benefit and interest from time to time in its member's interest together with all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juli 2001 Geliefert am 20. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 29 to 31 high street epsom t/n SY155018 and SY280929. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Jan. 2001 Geliefert am 22. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 11 to 17 bank street rugby t/n WK125353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 01. Dez. 2000 Geliefert am 14. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 3 to 7 (odd) high street bedford t/no.BD200012. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1999 Geliefert am 13. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 360/362 st johns street london EC2. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Juni 1999 Geliefert am 13. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Sept. 1998 Geliefert am 15. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from central investment properties limited ("the borrower") to the chargee in any manner whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a church house horsefair and 2 and 3 north bar banbury oxfordshire and the proceeds of sale thereof by way of floating charge all property and assets of whatsoever nature now or in the future owned or acquired by the company a specific equitable charge over all shares or membership rights or other rights an assignment of all the benefit of every insurance policy in respect of the property and assignment of the benefit of all guarantees warranties and reprsentations for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Juli 1998 Geliefert am 08. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Juli 1998 Geliefert am 08. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from central investment properties limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The church house horsefair and 2 and 3 north bar banbury oxfordshire and the proceeds of sale thereof and all compensation or grants payable. Floating charge over all property and assets of whatsoever nature. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0